WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYN UK DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01100599
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (4550) /

    Wo befindet sich WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    101 Wigmore Street
    W1U 1QU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARCADIAN U.K. DEVELOPMENTS LIMITED21. Dez. 199221. Dez. 1992
    WESTMINSTER & COUNTRY PROPERTIES (KING STREET) LIMITED08. März 197308. März 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution ;- "Books, Records,etc.
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Sept. 2012

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. März 2012

    Kapitalaufstellung am 27. März 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Change of registered office address 06/03/2012
    RES13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Wyndham International 65 Duke Street London W1K 5AJ am 23. März 2012

    2 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Pegler am 28. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    4 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STOLL, Peter Huston
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    Sekretär
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    American,107030970003
    ALBA, Glenn Emilio
    364 Stevens Avenue
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    07450
    Usa
    Geschäftsführer
    364 Stevens Avenue
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    07450
    Usa
    American112489010001
    PEGLER, Michael John
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    EnglandBritish113065790004
    STOLL, Peter Huston
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    Geschäftsführer
    Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    7
    United KingdomAmerican,107030970003
    BLUM, Edward Jesse
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    Sekretär
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    American65674420003
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    Sekretär
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    BRIGHT, Neil Irvine
    89 Nelson Road
    Wimbledon
    SW19 1HU London
    Sekretär
    89 Nelson Road
    Wimbledon
    SW19 1HU London
    British9736460001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    BLOUNT, Byron Gilbert
    5 Madrigal
    San Clemente
    Calafornia
    92673
    Usa
    Geschäftsführer
    5 Madrigal
    San Clemente
    Calafornia
    92673
    Usa
    American112490800001
    BLUM, Edward Jesse
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    Geschäftsführer
    2111 Carter Mill Way
    Brookeville
    Md 20833
    Usa
    American65674420003
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    American65674380001
    BOS, Patrick Albert
    5 St Michaels Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 St Michaels Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37135270001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Geschäftsführer
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    British38255700004
    CAMERON, John Douglas
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    Geschäftsführer
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    United KingdomBritish73541250001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66262660001
    HULLS, Michael Stanley
    32 Hatchgate Gardens
    SL1 8DD Burnham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    32 Hatchgate Gardens
    SL1 8DD Burnham
    Buckinghamshire
    British67081650001
    PARKES, David Brian
    28 Eaton Square
    SW1W 9DF London
    Geschäftsführer
    28 Eaton Square
    SW1W 9DF London
    British80771510001
    PRIESTLEY, Jeremy Robert
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Geschäftsführer
    8 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    EnglandBritish766060001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    American66261390001
    SOLLS, Mark Alan
    5314 Harbor Town Drive
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    Geschäftsführer
    5314 Harbor Town Drive
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    American85742190001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    UPTON, Christopher George
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    EnglandBritish103753080001

    Hat WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Mai 1996
    Geliefert am 11. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited the Banks (The "Security Trustee")for Itself and as Agent and Trustee on Behalf Of
    Transaktionen
    • 11. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 1994
    Geliefert am 08. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Sept. 1994
    Geliefert am 27. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Aug. 1994
    Geliefert am 06. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 08. Aug. 1990
    Geliefert am 16. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from westminster and country properties PLC to the chargee under the personal bond.
    Kurze Angaben
    278 west george street and 160 pitt street, glasgow strathclyde title no gla 33007.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security registred in scotland
    Erstellt am 23. Nov. 1989
    Geliefert am 29. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from westminster & country properties PLC to the chargee in terms of a personal bond dated 9/11/89
    Kurze Angaben
    110/114 bath street, glasgow title no: gla 57899.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Erstellt am 19. Sept. 1989
    Geliefert am 25. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 12/9/89
    Kurze Angaben
    All and whole a mixed development of retail and residential premises on ground floors k/a 80-102 channel street, galashiels and 71-87 overhaugh street galasheils in the burgh of galashiels at county of selkirk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 22. März 1989
    Geliefert am 10. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Anniesland industrial estate netherton road glasgow title no's gla 18678, gla 51825.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juli 1988
    Geliefert am 11. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    37 high street, kings lynn norfolk. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 1988
    Geliefert am 07. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    2/3 the highway, station road, beaconsfield.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Erstellt am 27. Mai 1988
    Geliefert am 02. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from westminster country properties PLC in terms of a personal bond dated 25/5/88 to the chargee
    Kurze Angaben
    All & whole that area or piece of ground containing 611 17/36 sq yds or thereby together with the whole buildings erected thereon k/a 226 west george street, glasgow and 114 to 118 west campbell street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 18. Jan. 1988
    Geliefert am 19. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3/19 high street barkingside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 31. Dez. 1987
    Geliefert am 13. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 29/12/87
    Kurze Angaben
    Area of ground extending to 2,072 yds approx at the junction of west george street and pitt street glasgow known as st judes house 278 west george street & 160 pitt street (including the bridge connecting st judes house with 21 blythswood square).
    Berechtigte Personen
    • Lilley Development Limited
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 31. Dez. 1987
    Geliefert am 11. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from westminster and country properties in terms of a personal bond dated 29/12/87 to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that area of ground extending to 2,272 sq yd lying at the junction of west george street and pitt street glasgow together with st judes house 278 west george street and 160 pitt street and car parking spaces to the buildings.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security registered in scotland
    Erstellt am 31. Dez. 1987
    Geliefert am 11. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from westminster & country properties PLC in terms of a personal bond dated 29/12/87 to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that area of ground of 1289 sq yds on the north side of west george street and west side of blythswood square glasgow together with the buildings at 21 blythwood square & 268 west george street.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Apr. 1987
    Geliefert am 24. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The windsor public house silver street, bedford, bedfordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over contract
    Erstellt am 11. Feb. 1987
    Geliefert am 03. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that benefit of agreement for sale purchase and development at jetty marsh road newton abbot devon dated 16/9/86 between westminster and country properties (king street) limited and westminster and country properties PLC and commercial union assurance company PLC.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Sept. 1986
    Geliefert am 22. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south-west side of marsh lane southampton. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Aug. 1986
    Geliefert am 03. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    16/18, rose street, workingham, berkshire land forming part of title no: bk 126699.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juli 1986
    Geliefert am 25. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the and/or westminster and country properties PLC company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land formerly known as 1-15 (odd nos inclusive) abbot street & 36, 38 & 40 kingsland high street and the amherst cinema kingsland high street, london borough of the hackney title nos ln 34159 & ln 21045.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 1986
    Geliefert am 20. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land situate on the south west side of market street falmouth cornwall together with buildings erected thereon or some part thereof k/a ground cinema market street falmouth.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 1986
    Geliefert am 20. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the galleon restaurant 7, victoria square, truro, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Feb. 1986
    Geliefert am 10. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 32/33 high street, lymington, hampshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 1986
    Geliefert am 06. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or westminster and country properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    38/40, westgate street gloucester gloucestershire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1985
    Geliefert am 24. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    "Getty marsh" getty marsh road newton abbot devon, and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat WYN UK DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    21. Mai 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0