HALLITE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHALLITE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01104611
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HALLITE LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HALLITE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HALLITE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HALLITE HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY28. März 197328. März 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLITE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für HALLITE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2021

    8 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2020

    8 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW zum C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL am 04. Feb. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Jan. 2019

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2019

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    The share premium account of the company be cancelled 13/12/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for Fenner Plc as a person with significant control on 11. Dez. 2018

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 10. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018

    1 SeitenAA01

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Aug. 2017

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 16. März 2018

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Simon Alan Davies als Geschäftsführer am 05. März 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1,403,811
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Maitland Caley am 03. Juli 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von HALLITE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRADBURY, Debra
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Sekretär
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    British72879990002
    CALEY, Andrew Maitland
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Geschäftsführer
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    United KingdomBritish49060800002
    PRATT, William John
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    Geschäftsführer
    1st Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    C/O Kingsbridge Corporate Solutions
    United KingdomBritish194710300003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Sekretär
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    British69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Sekretär
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    British119450490001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Sekretär
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British10035580002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British10035580002
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    BENNETT, Peter Ian
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    24 Coulter Close
    Cuffley
    EN6 4RR Potters Bar
    Hertfordshire
    British4154020001
    CHAFFIN, Peter
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    The Croft 21 The Ridgeway
    TN10 4NH Tonbridge
    Kent
    British1508410001
    DAVIES, Simon Alan
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    28 Stonebridge Field
    Eton
    SL4 6PS Windsor
    Berkshire
    British44598860003
    GILLETT, Christopher Joseph
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Lodge
    12 Ashurst Road
    KT20 5EU Tadworth
    Surrey
    Great BritainBritish69961270001
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    EnglandBritish119450490001
    JONES, David Henry
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Neen Court
    DY14 0AH Neen Sollars
    Worcestershire
    United KingdomBritish101383260001
    KINGSNORTH, Robert Stanley
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Dolphins 23 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British58131230001
    LYALL, Gordon John
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Hildegarth
    New Yatt
    OX8 6TF Witney
    Oxfordshire
    British15413660003
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PAVER, Michael
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    27 Cavendish Meads
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish10035580002
    PERRY, Richard John
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish40260860002
    WELLER, Christopher
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Halfway Cottages
    Bath Road
    RG20 8NG Newbury
    Berkshire
    British80664920001
    WILKINS, Christopher Stuart Henry
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Banktop House
    Hopton Lane Hopton
    ST18 0AH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish127017930001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALLITE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    06. Apr. 2016
    Hesslewood Country Office Park
    Ferriby Road
    HU13 0PW Hessle
    Unit 5
    East Yorkshire
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00329377
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HALLITE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1994
    Geliefert am 21. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. Limited, as Agent and Trustee for Itself, the Arranger and the Banks
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 23. Feb. 1990
    Geliefert am 13. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and the banks under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Sept. 1989
    Geliefert am 05. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the bank (as defined) at the banks (or any of them) under the terms of the agreement and the security documents referred to in the charge.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & second debenture
    Erstellt am 25. Aug. 1989
    Geliefert am 05. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • First Britannia Mezzanine Capital B V(For Itself and as Trustee for the Lenders)
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & second debenture
    Erstellt am 27. Juli 1989
    Geliefert am 17. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • First Britannia Mezzanine Capital B V
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 1989
    Geliefert am 07. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) on any account whatsoever. Under the terms of a facility agreement of even dated and the charge.
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and second debenture.
    Erstellt am 27. Juli 1989
    Geliefert am 07. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a mezzamine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed.
    Kurze Angaben
    (See form 395 reg M536C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • First Britannia Mezzanine Capital B V(As Trustee for the Lenders)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 1985
    Geliefert am 13. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the north western and south western side of holly road and on the south eastern side of sherland road, london borough of richmond upon thames title no mx 129433.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 1985
    Geliefert am 13. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    108,Sherland road and land and buildings on the south eastern and south western sides of sherland road and with north western side of holly road london borough of richmond upon thames title no mx 129432.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1985Registrierung einer Belastung

    Hat HALLITE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Jan. 2019Beginn der Liquidation
    13. Nov. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah Louise Burge
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull
    Praktiker
    First Floor Lowgate House
    Lowgate
    HU1 1EL Hull

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0