HALLITE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HALLITE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01104611 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HALLITE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HALLITE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HALLITE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HALLITE HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 28. März 1973 | 28. März 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLITE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HALLITE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2021 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2020 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hesslewood Country Office Park Ferriby Road Hessle East Yorkshire HU13 0PW zum C/O Kingsbridge Corporate Solutions 1st Floor Lowgate House Lowgate Hull HU1 1EL am 04. Feb. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Change of details for Fenner Plc as a person with significant control on 11. Dez. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 10. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Aug. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William John Pratt am 16. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Alan Davies als Geschäftsführer am 05. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Maitland Caley am 03. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HALLITE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADBURY, Debra | Sekretär | 1st Floor Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions | British | 72879990002 | ||||||
| CALEY, Andrew Maitland | Geschäftsführer | 1st Floor Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions | United Kingdom | British | 49060800002 | |||||
| PRATT, William John | Geschäftsführer | 1st Floor Lowgate House Lowgate HU1 1EL Hull C/O Kingsbridge Corporate Solutions | United Kingdom | British | 194710300003 | |||||
| GILLETT, Christopher Joseph | Sekretär | White Lodge 12 Ashurst Road KT20 5EU Tadworth Surrey | British | 69961270001 | ||||||
| HARDACRE, Eian Clark | Sekretär | 6 Wilcot Close Bisley GU24 9DE Woking Surrey | British | 119450490001 | ||||||
| LYALL, Gordon John | Sekretär | Hildegarth New Yatt OX8 6TF Witney Oxfordshire | British | 15413660003 | ||||||
| PAVER, Michael | Sekretär | 27 Cavendish Meads SL5 9TB Ascot Berkshire | British | 10035580002 | ||||||
| PAVER, Michael | Sekretär | 27 Cavendish Meads SL5 9TB Ascot Berkshire | British | 10035580002 | ||||||
| WELLER, Christopher | Sekretär | 3 Halfway Cottages Bath Road RG20 8NG Newbury Berkshire | British | 80664920001 | ||||||
| BENNETT, Peter Ian | Geschäftsführer | 24 Coulter Close Cuffley EN6 4RR Potters Bar Hertfordshire | British | 4154020001 | ||||||
| CHAFFIN, Peter | Geschäftsführer | The Croft 21 The Ridgeway TN10 4NH Tonbridge Kent | British | 1508410001 | ||||||
| DAVIES, Simon Alan | Geschäftsführer | 28 Stonebridge Field Eton SL4 6PS Windsor Berkshire | British | 44598860003 | ||||||
| GILLETT, Christopher Joseph | Geschäftsführer | White Lodge 12 Ashurst Road KT20 5EU Tadworth Surrey | Great Britain | British | 69961270001 | |||||
| HARDACRE, Eian Clark | Geschäftsführer | 6 Wilcot Close Bisley GU24 9DE Woking Surrey | England | British | 119450490001 | |||||
| JONES, David Henry | Geschäftsführer | Neen Court DY14 0AH Neen Sollars Worcestershire | United Kingdom | British | 101383260001 | |||||
| KINGSNORTH, Robert Stanley | Geschäftsführer | The Dolphins 23 Kingsley Avenue GU15 2NA Camberley Surrey | British | 58131230001 | ||||||
| LYALL, Gordon John | Geschäftsführer | Hildegarth New Yatt OX8 6TF Witney Oxfordshire | British | 15413660003 | ||||||
| PAVER, Michael | Geschäftsführer | 27 Cavendish Meads SL5 9TB Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 10035580002 | |||||
| PAVER, Michael | Geschäftsführer | 27 Cavendish Meads SL5 9TB Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 10035580002 | |||||
| PERRY, Richard John | Geschäftsführer | Hesslewood Country Office Park Ferriby Road HU13 0PW Hessle East Yorkshire | United Kingdom | British | 40260860002 | |||||
| WELLER, Christopher | Geschäftsführer | 3 Halfway Cottages Bath Road RG20 8NG Newbury Berkshire | British | 80664920001 | ||||||
| WILKINS, Christopher Stuart Henry | Geschäftsführer | Banktop House Hopton Lane Hopton ST18 0AH Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 127017930001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALLITE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenner Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Hesslewood Country Office Park Ferriby Road HU13 0PW Hessle Unit 5 East Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HALLITE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 31. Jan. 1994 Geliefert am 21. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 23. Feb. 1990 Geliefert am 13. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and the banks under the terms of an agreement (as defined in the original debenture) and any document evidencing the provision of an ancillary facility and/or such of the security documents and under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 1989 Geliefert am 05. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the bank (as defined) at the banks (or any of them) under the terms of the agreement and the security documents referred to in the charge. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & second debenture | Erstellt am 25. Aug. 1989 Geliefert am 05. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 27/7/89 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & second debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 17. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) on any account whatsoever. Under the terms of a facility agreement of even dated and the charge. | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and second debenture. | Erstellt am 27. Juli 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a mezzamine loan agreement dated 27TH july 1989 and the deed. | |
Kurze Angaben (See form 395 reg M536C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Aug. 1985 Geliefert am 13. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north western and south western side of holly road and on the south eastern side of sherland road, london borough of richmond upon thames title no mx 129433. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Aug. 1985 Geliefert am 13. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 108,Sherland road and land and buildings on the south eastern and south western sides of sherland road and with north western side of holly road london borough of richmond upon thames title no mx 129432. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HALLITE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0