IN SHOPS CENTRES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIN SHOPS CENTRES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01105709
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE MIDLAND DEVELOPMENT GROUP OF COMPANIES PLC02. Apr. 197302. Apr. 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    22 SeitenLIQ14

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    31 SeitenLIQ06

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2018

    24 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2018

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2017

    24 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    18 Seiten4.33

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2016

    22 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2015

    21 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester M2 6DS zum 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 26. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Burnett als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Frederick Bonnet als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jean Auguste als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michel Distel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Gray als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:form 4.28 - certificate of appointment of two or more liquidators
    1 SeitenLIQ MISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Wer sind die Geschäftsführer von IN SHOPS CENTRES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOOKER, Julie Anne
    21 Turnbury Road
    Sharston
    M22 4ZB Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    21 Turnbury Road
    Sharston
    M22 4ZB Manchester
    Lancashire
    British109766350001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    GRAY, Stephen John
    Moel Famau View
    Aigburth
    L17 7ET Liverpool
    25
    Merseyside
    England
    Sekretär
    Moel Famau View
    Aigburth
    L17 7ET Liverpool
    25
    Merseyside
    England
    161676850001
    LAWS, George
    3 Broad Lane
    Holmes Chapel
    CW4 7LY Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    3 Broad Lane
    Holmes Chapel
    CW4 7LY Crewe
    Cheshire
    British21533070001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Sekretär
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    SALMON, Steven Kenneth
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Sekretär
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    British66565200002
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Sekretär
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    ADAMS, Peter Frederick
    7 Cherry Close
    Offenham
    WR11 5SQ Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    7 Cherry Close
    Offenham
    WR11 5SQ Evesham
    Worcestershire
    British60039620002
    AUGUSTE, Jean Paul
    27 Boulevard De La Republique
    93160 Livry Gargan
    France
    Geschäftsführer
    27 Boulevard De La Republique
    93160 Livry Gargan
    France
    FranceFrench96444970001
    AVERY, Ray Arnold Charles
    Bromley Farm Court
    Woodford Halse
    NN11 3PU Daventry
    3
    Northamptonshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Bromley Farm Court
    Woodford Halse
    NN11 3PU Daventry
    3
    Northamptonshire
    Uk
    United KingdomBritish134637730001
    BARNES, Ian Malcolm
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish37745750001
    BONNET, Frederick Albert Fernand
    Wholesale Fruit & Vegetable Market
    Edge Lane
    L13 2EJ Liverpool
    The Geraud Centre
    Merseyside
    England
    Geschäftsführer
    Wholesale Fruit & Vegetable Market
    Edge Lane
    L13 2EJ Liverpool
    The Geraud Centre
    Merseyside
    England
    FranceBritish180678640001
    BROOKES, Timothy Alastair Edward
    Holt
    WR6 6TX Worcester
    Bentley Court
    Worcestershire
    England
    Geschäftsführer
    Holt
    WR6 6TX Worcester
    Bentley Court
    Worcestershire
    England
    EnglandEnglish36187190004
    BURNETT, Andrew
    The Threshing Barn; 4
    Coley Mill Barns, Coley Lane
    TF10 9DA Newport
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Threshing Barn; 4
    Coley Mill Barns, Coley Lane
    TF10 9DA Newport
    Shropshire
    EnglandBritish87921620002
    CALLAN, Michael Leigh
    44 Crawshaw Grange
    Crawshawbooth
    BB4 8LY Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    44 Crawshaw Grange
    Crawshawbooth
    BB4 8LY Rossendale
    Lancashire
    British47630520002
    CHAPMAN, Robert William Thomas
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    16 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish32652350001
    CHRISTOPHER, Jack
    12 Ashfield Close
    S12 2QU Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Ashfield Close
    S12 2QU Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish52727260001
    CRAN, William Michael
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Ashleigh Dale
    Birkby
    HD2 2DL Huddersfield
    West Yorkshire
    British5206400002
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    DISTEL, Michel
    44 Boulevard Raspail
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Geschäftsführer
    44 Boulevard Raspail
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FranceFrench63502910001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    FARRANDS, Helen Ruth
    129 Bournbrook Road
    B29 7BY Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    129 Bournbrook Road
    B29 7BY Birmingham
    West Midlands
    British93644320001
    HERRITTY, Jayne
    11 Milcote Drive
    B73 6QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    11 Milcote Drive
    B73 6QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British45641090002
    HINE, Derek Leslie
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    8 Showell Close
    Westwood Court
    WR9 8UQ Droitwich
    Worcestershire
    British29871470001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    KIRKWOOD, Stuart Watson
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    British76937270002
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    EnglandBritish5785520001
    O'MALLEY, John Francis
    2 Monwood Grove
    B91 1PB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    2 Monwood Grove
    B91 1PB Solihull
    West Midlands
    Irish47630590003
    OVENS, Mark Douglas
    11 Barrow Hedges Way
    SM5 3LL Carshalton
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Barrow Hedges Way
    SM5 3LL Carshalton
    Surrey
    British56734030002
    ROSE, Cedric Henry
    7 Woodridge Avenue
    Allesley
    CV5 7PN Coventry
    West Midlands
    Geschäftsführer
    7 Woodridge Avenue
    Allesley
    CV5 7PN Coventry
    West Midlands
    British20048510001
    SALMON, Steven Kenneth
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Oakridge 8 Carters Close
    B61 7HJ Bromsgrove
    Worcestershire
    British66565200002
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Geschäftsführer
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritish32981540001
    SPRINGALL, Charles Alexander
    26 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    26 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    EnglandBritish79884190001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Geschäftsführer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001

    Hat IN SHOPS CENTRES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    154/156 front street, chester le street, county durham, t/no DU167347. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    855 to 857 bristol road, south northfield, birmingham, t/no WK169592. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The arcade and 7 and 9 church street and maximillians wine bar, warner street, accrington t/nos LA582718 and LA643355. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    39A, 41 and 43 high street and land lying to the east of high street, kingsheath t/no WM337683. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground and mezzanine floor premises, telegraph way (formerly hall lane and st chad's drive) kirkby, merseyside t/no MS66400. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The wilton market, high street, erdington, birmingham t/no WK207407. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Eldon arcade, 29 eldon street and 11 midland street, barnsley t/no SYK399696. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    35 to 43 (odd) high street and land on the south side of gordon road, wealdstone t/nos MX143654 and MX443641. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14, 14A, 16, 16A and 18 middle street and 12, 14 and 16 queen street, consett, county durham t/no DU153106. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest under the lease of the subjects k/a market hall (indoor) 13 hamilton gate greenock t/no REN72389.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest under the lease of the subjects being shop unit k/a market hall paisley centre paisley at level 2 t/no REN75079.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the property k/a the ground floor savoy centre renfrew street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising lower mall floor level unit store a forge shopping centre 1221 gallowgate glasgow t/no GLA62447.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest in the lease of the lettable units. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the interest of the sub-tenant in the sub-under-lease of the subjects 36 sylvania way south clydebank t/no DMB10208. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the interest of the sub-tenant in the sub-under-lease of the subjects 41 sylvania way south clydebank t/no DMB15368. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects now k/a 42 to 48 (inclusive) high street ayr lying in the burgh and county of ayr. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the property k/a the ground floor savoy centre renfrew street glasgow.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest in the lease in respect of those parts of the subjects k/a the market building union street in the city and county of aberdeen.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 september 2003 and
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from zipmodes to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming unit 13A shandwick square shopping centre easterhouse glasgow t/no GLA70058 and all and whole the subjects k/a and forming store number 3 shandwick square shopping centre easterhouse glasgow t/no GLA70057.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2002
    Geliefert am 01. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 19. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a or being 39A,41 & 43 high street & land lying to the east of high street kings heath.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 18. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    45 boroughgate otley yorks west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat IN SHOPS CENTRES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Jan. 2014Beginn der Liquidation
    15. Apr. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praktiker
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praktiker
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0