THE FIELDING GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE FIELDING GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01111055
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE FIELDING GROUP LIMITED?

    • Großhandel mit Bekleidung und Schuhen (46420) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o RESOLVE PARTNERS LIMITED
    One America Square
    17 Crosswall
    EC3N 2LB London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UNIDOOR INTERNATIONAL LIMITED01. Dez. 199301. Dez. 1993
    UNIDOOR LIMITED01. Mai 197301. Mai 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Dez. 2015

    32 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 22. Dez. 2015

    32 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Nov. 2015

    28 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Resolve Partners Llp One America Square Crosswall London EC3N 2LB zum C/O Resolve Partners Limited One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB am 03. Nov. 2015

    1 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Mai 2015

    48 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Dez. 2014

    38 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    2 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    78 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    78 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    19 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Tfg House Eyncourt Road Woodside Estate Dunstable Bedfordshire LU5 4TS* am 03. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Christopher Bugden als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 011110550009

    42 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    23 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Damian Hopkins als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 SeitenRP04
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    20. Jan. 2014Second filing TM01 for James Clark

    Beendigung der Bestellung von Christopher Bugden als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Clark als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    20. Jan. 2014A second filed TM01 was registered on 20/01/2014

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    24 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von THE FIELDING GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TUCH, Peter Ellis
    The Hall House
    Broad Oak End
    SG14 2JA Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Hall House
    Broad Oak End
    SG14 2JA Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish60777430002
    WOLFF, Michael Fielding
    Haydon Hill House Merry Hill Road
    WD23 1DU Bushey
    1
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Haydon Hill House Merry Hill Road
    WD23 1DU Bushey
    1
    Hertfordshire
    EnglandBritish50067270002
    BUGDEN, Christopher
    Churchill Way
    SG17 5UB Shefford
    1
    Bedfordshire
    England
    Sekretär
    Churchill Way
    SG17 5UB Shefford
    1
    Bedfordshire
    England
    British137267180001
    DUQUE, Ian
    292 Cranbrook Road
    IG1 4UR Ilford
    Essex
    Sekretär
    292 Cranbrook Road
    IG1 4UR Ilford
    Essex
    British36779230001
    LANDE, Paul Charles
    14 Harford Walk
    N2 0JB London
    Sekretär
    14 Harford Walk
    N2 0JB London
    British52215750002
    ATKINSON, Fiona Ann
    Manor Hill Cottage Galley Lane
    Great Brickhill
    MK17 9AB Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Manor Hill Cottage Galley Lane
    Great Brickhill
    MK17 9AB Milton Keynes
    British37738810003
    ATKINSON, Fiona Ann
    12 Caedmon Road
    N7 6DH London
    Geschäftsführer
    12 Caedmon Road
    N7 6DH London
    British37738810001
    BENJAMIN, Alan
    9 Bankside Close
    Houghton Rgis
    LU5 6JP Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    9 Bankside Close
    Houghton Rgis
    LU5 6JP Dunstable
    Bedfordshire
    British42701480002
    BUGDEN, Christopher Paul
    Tfg House
    Eyncourt Road Woodside Estate
    LU5 4TS Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Tfg House
    Eyncourt Road Woodside Estate
    LU5 4TS Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish171150050001
    CLARK, James Kenneth
    Floor)
    Mcneil Drive
    ML1 4UR Motherwell
    Precision House (2nd
    Lanarkshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Floor)
    Mcneil Drive
    ML1 4UR Motherwell
    Precision House (2nd
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish54276640002
    HOPKINS, Damian Andrew
    Tfg House
    Eyncourt Road Woodside Estate
    LU5 4TS Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Tfg House
    Eyncourt Road Woodside Estate
    LU5 4TS Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish70831620002
    JACK, Stephen William
    23 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    23 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    United KingdomBritish22596620003
    LANDE, Paul Charles
    14 Harford Walk
    N2 0JB London
    Geschäftsführer
    14 Harford Walk
    N2 0JB London
    EnglandBritish52215750002
    PHILLIPS, Gerald Joseph
    47 Wren Court
    WD2 1AN Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    47 Wren Court
    WD2 1AN Bushey Heath
    Hertfordshire
    British36803530001
    ROSTON, Marlene Suzanne
    5 Shepherds Walk
    WD23 1LZ Bushey
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Shepherds Walk
    WD23 1LZ Bushey
    Hertfordshire
    EnglandBritish80075330001
    ROSTON, Michael
    5 Shepherds Walk Hartsbourne Road
    Bushey Heath
    WD2 1LZ Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Shepherds Walk Hartsbourne Road
    Bushey Heath
    WD2 1LZ Watford
    Hertfordshire
    British3652240002
    ROSTON, Paul Martin
    Fernworthy Bridle Lane
    Loudwater
    WD3 4JQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernworthy Bridle Lane
    Loudwater
    WD3 4JQ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish26503580002
    ROSTON, Robert Mark
    Eastway Cottage East End Way
    HA5 3BS Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Eastway Cottage East End Way
    HA5 3BS Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish22596640002
    ROSTON, Stephen
    21 West Drive
    HA3 6TX Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    21 West Drive
    HA3 6TX Harrow
    Middlesex
    British44440440002
    SMITH, Peter John
    Ash Cottage 27 Fowlmere Road
    Heydon
    SG8 8PZ Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Ash Cottage 27 Fowlmere Road
    Heydon
    SG8 8PZ Royston
    Hertfordshire
    British27197170001
    WILLIAMS, Robert Harry
    178 Marleyfields
    LU7 8WN Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    178 Marleyfields
    LU7 8WN Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British26503560001

    Hat THE FIELDING GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 09. Mai 2014
    Geliefert am 14. Mai 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    A. by way of first legal mortgage the specified real property (if any);. B. by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a));. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (B) C. by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3;. (c) D. by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1 (q);. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Centric SPV1 Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 31. Okt. 2006
    Geliefert am 01. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Okt. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Juni 1997
    Geliefert am 25. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Mai 1988
    Geliefert am 17. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 137 & 139 essex road c 9 and 10 astey's row london N1 t/no ln 147838 8 ashtey's row london N1. T/no. T/no. Ln 170564UNCALLED capital. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 1988
    Geliefert am 07. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties known as 137 and 139 essex road and 9 and 10 astey's row london N1 title no ln 147838 and 8 astey's row, london N1 title no - 170564.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 1985
    Geliefert am 20. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over 137 and 139 essex road, islington N1 title no ln 147838 and 8, 9, and 10 asteys row islington N1 title no ln 170564 floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture.
    Berechtigte Personen
    • A. P Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 13. Juni 1985
    Geliefert am 20. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage all f/hold and l/hold property with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed, plant and machinery. A specific equitable charge over all future f/hold and l/hold property buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant machinery goodwill and uncalled capital including book debts and other debts floating charge over under taking property assets and rights both present and future.
    Berechtigte Personen
    • A. P. Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 22. März 1983
    Geliefert am 24. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Specific equitable charge over all f/hold and e/hold property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • P. S. Refson & Co Limited
    Transaktionen
    • 24. März 1983Registrierung einer Belastung

    Hat THE FIELDING GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Juni 2014Beginn der Verwaltung
    22. Dez. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Praktiker
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Cameron Gunn
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Praktiker
    One America Square
    EC3N 2LB Crosswall
    London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    Praktiker
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0