CHUBB EUROPEAN GROUP PLC
Überblick
| Unternehmensname | CHUBB EUROPEAN GROUP PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 01112892 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Leadenhall Street EC3A 3BP London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED | 02. Mai 2017 | 02. Mai 2017 |
| ACE EUROPEAN GROUP LIMITED | 13. Sept. 2004 | 13. Sept. 2004 |
| ACE INA UK LIMITED | 30. Dez. 2002 | 30. Dez. 2002 |
| INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA (U.K.) LIMITED | 20. Juni 1978 | 20. Juni 1978 |
| SIGNAL IMPERIAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 09. Mai 1973 | 09. Mai 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2018 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedene Hypotheken für Belastung This is not a charge document. On 19TH July 2018 the company converted to a societas euroapea. Previous filings for this is company including charges were filed when the company was a PLC 1112892. The PLC record includes charges registered before 19/07/2018 which can be viewed on the mortgage register. | 1 Seiten | MORT MISC | ||||||||||
Aktienkonsolidierung und Aktienspaltung am 11. Juni 2018 | 6 Seiten | SH02 | ||||||||||
Umbrechnungsbetrag der Aktien. Kapitalaufstellung 11. Juni 2018
| 6 Seiten | SH14 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CLOMERGE | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jalil Ur Rehman als Geschäftsführer am 11. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 24 Seiten | MA | ||||||||||
legacy | 210 Seiten | DTOM | ||||||||||
Cessation of Chubb Insurance Investment Holdings Ltd as a person with significant control on 11. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Ace European Holdings No 2 Limited as a person with significant control on 11. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bilanz | 1 Seiten | BS | ||||||||||
Bericht des Auditors | 6 Seiten | AUDR | ||||||||||
Erklärung des Auditors | 1 Seiten | AUDS | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft | 1 Seiten | CERT5 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 24 Seiten | MAR | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft | 5 Seiten | RR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeff Moghrabi als Geschäftsführer am 31. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 65 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. März 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUBB LONDON SERVICES LIMITED | Sekretär | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom |
| 73849550003 | ||||||||||
| BAILEY, Marshall Charles | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 187892510002 | |||||||||
| HAMMOND, Mark Kent | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | American | 174190760002 | |||||||||
| KENDRICK, Andrew James | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 62276900004 | |||||||||
| O'SHIEL, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Ireland | Irish | 218698440002 | |||||||||
| RILEY, Cathryn Elizabeth | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | England | British | 127925720001 | |||||||||
| ROBINSON, David Peter | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | England | British | 169884710001 | |||||||||
| SHAW, Alexander Matthew Wenham | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | England | British | 153998660001 | |||||||||
| TURNER, Jonathan Adair, Lord | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 236422570001 | |||||||||
| WADE, Timothy Cardwell | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 136831040002 | |||||||||
| ELLENDER, John Eric | Sekretär | 30 Bodsham Crescent Bearsted ME15 8NL Maidstone Kent | British | 5267650001 | ||||||||||
| LIDDELL, Graeme Ian | Sekretär | 23 Tennyson Close RH12 5PN Horsham West Sussex | British | 51474650001 | ||||||||||
| ABDALLAH, Michael Joseph | Geschäftsführer | 48 Ince Road Burwood Park KT12 5BJ Walton On Thames Surrey | Australian | 14076920002 | ||||||||||
| BACH, Carl Lee | Geschäftsführer | Flat 16 Tudor Grange 83 Oatlands Drive KT13 9LN Weybridge Surrey | American | 81856890001 | ||||||||||
| CASTLE, Stephen Victor | Geschäftsführer | 31 Dome Hill CR3 6EF Caterham Surrey | British | 50415920002 | ||||||||||
| CIGELNIK, Randi Lyn | Geschäftsführer | 28 Pilgrims Lane NW3 1SN London | American | 88380810001 | ||||||||||
| CLABBY, Joseph Stephen | Geschäftsführer | Ace Building 100 Leadenhall Street EC3A 3BP London | France | American | 155540760002 | |||||||||
| COLLINS, Donald Eric | Geschäftsführer | Barn House Wierton Hill Boughton Monchelsea ME17 4JS Maidstone Kent | British | 10806890002 | ||||||||||
| COX, Malcolm John | Geschäftsführer | Ace Building 100 Leadenhall Street EC3A 3BP London | United Kingdom | British | 29245010001 | |||||||||
| CURTIS, Philippa Mary | Geschäftsführer | Flat 20 St Hilda's Wharf 160 Wapping High Street E1W 3PG London | United Kingdom | British | 40995560001 | |||||||||
| DAVIS, Lawrence Stewart | Geschäftsführer | 15 Abercorn Place NW8 9EA London | American (Usa) | 14076860001 | ||||||||||
| DRINAN, Patrick | Geschäftsführer | Ace Building 100 Leadenhall Street EC3A 3BP London | United Kingdom | Irish | 170347530003 | |||||||||
| EMERSON, Ronald Victor | Geschäftsführer | The Reeds Remenham Lane, Remenham RG9 3DA Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 75081610001 | |||||||||
| FURBY, David Michael Alan | Geschäftsführer | 55 Avenue Foch FOREIGN Paris 75116 France | British | 108295630001 | ||||||||||
| FURGUESON, Michael Graham | Geschäftsführer | 53 Onslow Road KT12 5BA Walton On Thames Surrey | American | 98989530001 | ||||||||||
| GASKELL, Spencer Walton | Geschäftsführer | 14 Furze View Chorleywood WD3 5HU Rickmansworth Hertfordshire | British | 14076870001 | ||||||||||
| GLOVER, Michael Logan | Geschäftsführer | Dunelm 41. St. Catherines Road EN10 7LD Broxbourne Herts | British | 94249710001 | ||||||||||
| HOLLENBERG, Abraham Andrew | Geschäftsführer | 23 Sandown Road KT10 9TT Esher Surrey | United Kingdom | Canadian | 127416860001 | |||||||||
| HORNIG, Gerhard Friedrich Wilhelm | Geschäftsführer | Flat 309 Butlers Wharf Building 36 Shad Thames SE1 2YE London | German | 36373210002 | ||||||||||
| HOWIE, William Hamish | Geschäftsführer | Church House Church St TN14 7SB Shoreham Kent | United Kingdom | British | 49611820001 | |||||||||
| JAKSIC, Drazen | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 134420370002 | |||||||||
| KENDRICK, Andrew James | Geschäftsführer | 23 Klea Avenue SW4 9HG London | United Kingdom | British | 62276900003 | |||||||||
| LEVIN, Edward M | Geschäftsführer | 37 Gwendolen Avenue SW15 6EP London | American | 108295480001 | ||||||||||
| LIDDELL, Graeme Ian | Geschäftsführer | 23 Tennyson Close RH12 5PN Horsham West Sussex | British | 51474650001 | ||||||||||
| MARSTON, Davida Sara | Geschäftsführer | Lakeside Grange KT13 9ZE Weybridge 21 Surrey England | United Kingdom | British | 79305400002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHUBB EUROPEAN GROUP PLC?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Insurance Investment Holdings Ltd | 01. Mai 2017 | 17 Crosswall EC3N 2AD London One America Square United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Chubb Insurance Investment Holdings Ltd | 01. Mai 2017 | 17 Crosswall EC3N 2AD London One America Square United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ace European Holdings No 2 Limited | 06. Apr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ace European Holdings No 2 Limited | 06. Apr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ace European Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ace European Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 3BP London 100 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHUBB EUROPEAN GROUP PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A pledge agreement | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first priority security interest in and a lien on all of the right title and interest whether now owned or hereafter acquired in the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 02. Juli 2002 Geliefert am 11. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyd tsb PLC re: insurance company of north america (UK) limited and numbered 01056781 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 27. Aug. 1996 Geliefert am 16. Sept. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the security asgreement any agreement or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All securities which are held by to the order for the account or under the control or direstion of the custodian and all rights benefits and proceeds attaching to or arising from or in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement (portfolio third party custodian) | Erstellt am 01. Okt. 1992 Geliefert am 15. Okt. 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security agreement,any other agreement or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all securities,benefits and proceeds, all sums of money standing to the credit of any account (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Reinsurance deposit agreement | Erstellt am 17. Juli 1988 Geliefert am 27. Juli 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies constituted by the reinsurance deposit agreement standing to the credit of the account & all entitlements to interest & other rights & benefits accruing. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0