TEXAS HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTEXAS HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01116472
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Oaklands 68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TEXAS GROUP PLC13. Apr. 198913. Apr. 1989
    TEXAS GROUP OF COMPANIES LIMITED14. Jan. 198714. Jan. 1987
    TEXAS METAL INDUSTRIES LIMITED04. Juni 197304. Juni 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Nov. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Aug. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis05. Mai 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung19. Mai 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis05. Mai 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2023

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2022

    8 SeitenAA

    Change of details for Mr Michael Anthony Mcdonald as a person with significant control on 05. Mai 2017

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Barton Hall Hardy Street Eccles Manchester M30 7NB zum Oaklands 68 Crofts Bank Road Urmston Manchester M41 0UH am 15. Mai 2023

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2021

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2020

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2019

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Mark Mcdonald am 21. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart James Mollekin am 15. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Kean Mcdonald am 15. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Jones am 15. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2018

    17 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2017

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    4 SeitenMR04

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2016

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2015

    22 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MOLLEKIN, Stuart James
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Sekretär
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    British36939710003
    JONES, Thomas
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Geschäftsführer
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    EnglandBritishSolicitor9001390002
    MCDONALD, James Mark
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Geschäftsführer
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    EnglandBritishCompany Director89192180003
    MCDONALD, Robert Kean
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Geschäftsführer
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    EnglandBritishCompany Director45512800002
    MOLLEKIN, Stuart James
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Geschäftsführer
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    EnglandBritishAccountant36939710004
    MCDONALD, Pauline
    Hobb Hill Farm
    Hague Street Whitfield
    SK13 8NS Glossop
    Derbyshire
    Sekretär
    Hobb Hill Farm
    Hague Street Whitfield
    SK13 8NS Glossop
    Derbyshire
    British35616300001
    MITCHELMORE, Gayle Sonia
    22 Chestnut Avenue
    Cadishead
    M44 5ZG Manchester
    Sekretär
    22 Chestnut Avenue
    Cadishead
    M44 5ZG Manchester
    BritishFinancial Controller91477350001
    WORSLEY, David
    Grimeford Farm
    Anderton
    PR6 9HP Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    Grimeford Farm
    Anderton
    PR6 9HP Chorley
    Lancashire
    BritishFinancial Director14768640003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    BritishDirector75952680002
    HEYWOOD, Maria Theresa
    63 Denton Road
    Audenshaw
    M34 5BL Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    63 Denton Road
    Audenshaw
    M34 5BL Manchester
    Lancashire
    BritishSecretary7350640001
    MANNING, Paul Hurton
    4 Fawns Keep Mottram Rise
    SK15 2UL Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Fawns Keep Mottram Rise
    SK15 2UL Stalybridge
    Cheshire
    EnglandBritishDirector54192630001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director51141710003
    MCDONALD, Terence
    21 Wheatfield
    SK15 2TZ Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    21 Wheatfield
    SK15 2TZ Stalybridge
    Cheshire
    BritishMetal Merchant7350660001
    POMFRET, Adrian Philip
    2 Langdale Close
    Denton
    M34 6JU Tameside
    Manchester
    Geschäftsführer
    2 Langdale Close
    Denton
    M34 6JU Tameside
    Manchester
    BritishManager54315100001
    TURNBULL, Laurence Andrew
    Penarwel House
    Llanbedrog
    LL55 7NN Pwllheli
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    Penarwel House
    Llanbedrog
    LL55 7NN Pwllheli
    Gwynedd
    Wales
    WalesBritishConsultant38480910001
    WILLMOTT, Brian John
    6 Westmoreland Close
    PE8 6QR Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    6 Westmoreland Close
    PE8 6QR Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector92725860001
    WORSLEY, David
    Grimeford Farm
    Anderton
    PR6 9HP Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Grimeford Farm
    Anderton
    PR6 9HP Chorley
    Lancashire
    BritishFinancial Director14768640003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TEXAS HOLDINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Anthony Michael Mcdonald
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    05. Mai 2017
    68 Crofts Bank Road
    Urmston
    M41 0UH Manchester
    Oaklands
    England
    Nein
    Nationalität: Belgian
    Staatsangehörigkeit: Belgium
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat TEXAS HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Mai 2011
    Geliefert am 04. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2005
    Geliefert am 12. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £500,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    First floating charge of all assets.
    Berechtigte Personen
    • Exius Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 22. Nov. 2004
    Geliefert am 26. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 63097842 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 06. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 1999
    Geliefert am 19. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Exact house 10 whitacre road nuneaton warwickshire t/no: WK344857. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 1999
    Geliefert am 19. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the north side of cut lane derby in the county of derbyshire t/no: DY156519. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Sept. 1998
    Geliefert am 06. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a exact house,10 whiteacre road,nuneaton,warwickshire.t/no.WK344857.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 1996
    Geliefert am 02. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All monies secured by the legal charge dated 12TH september 1996 and all benefits and moneys therein contained. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1996
    Geliefert am 27. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 whitacre road, nuneaton t/no: WK344857.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1995
    Geliefert am 31. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings on the east side of oldham st,denton,tameside,gt.manchester known as tate pipeline building; t/no.gm 312627 with all fixtures/fittings,plant,machinery......etc.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 1994
    Geliefert am 22. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (or any company controlled by the company or by and associated,subsidiary or parent company of the company) to bass brewers limited or to any associated,subsidiary or parent company of bass on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage and fixed charge all the property k/a the hyde botanical and horticultural club manchester road hyde cheshire (as defined in the legal charge ) by way of lfoating charge all that equipment and the stock-in-trade (as defined in the legal charge).
    Berechtigte Personen
    • Bass Brewers Limited
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 31. Dez. 1993
    Geliefert am 20. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever,but limited to the company's liability under their GUA0ANTEE to beevor foundry limited of even date
    Kurze Angaben
    Details of charged account(s) barclays bank PLC re texas group PLC pursuant to their guarantee in favour of beevor foundry limited dated 31 december 1993 high interest business acccount number 20003786. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 22. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies at any time standing to the credit of a bank account presentlynumbered 20053296 with the bank in the mname of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 1993
    Geliefert am 03. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By legal mortgage freehold property known as the duke of sussex victoria street newton hyde greater manchester title no. GM520231. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 1993
    Geliefert am 03. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage freehold property known as the oddfellows arms moorend road mellor marple greater manchester title no.GM526755. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 1993
    Geliefert am 03. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold property known as the beehive hague street whitfield glossop derbyshire title no. DY193716. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 1992
    Geliefert am 13. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the admiral rodney hotel and 10 and 12 north st,horncastle east lindsey county of lincolnshire t/n LL474941 including all fixtures and fittings see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juni 1992
    Geliefert am 17. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a talk of the north, liverpool road, eccles in the city of manchester t/no: gm 272264 including all fixtures & fittings (otherthan trade fixtures & fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1992
    Geliefert am 17. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property fronting to liverpool road,eccles in the county of greater manchester together with the buildings k/a the airport hotel including all fixtures & fittings (other than trade fixtures & fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Aug. 1991
    Geliefert am 14. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H beevor foundry beevor street lincoln floating charge over all movable plant machinery and equipment. (Please see doc for details).
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge.
    Erstellt am 22. Apr. 1988
    Geliefert am 29. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of a bank account (presently numbered 05001954) with the bank in the name of the company (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC.
    Transaktionen
    • 29. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 1987
    Geliefert am 01. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or texas metal industries limited and/or T.M.I. (metals) limited and/or G. hopwood & sons limited and/or E.S. honey limited and/or texas demolitions limited to yorkshire bank PLC under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 11. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 1987
    Geliefert am 22. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from texas metal industries limited and/or texas alloys limited and/or E.S. honey limited and/or T.M.I. (metals) limited and/or texas demolitions limited to yorkshire bank PLC on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Gatefield works whitelands road ashton under lyne all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant & machinery. Floating charge over all plant machinery and equipment materials & articles.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC.
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 24. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Aug. 1987
    Geliefert am 12. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from texas metal industries limited, T.M.I. (metals) limited, texas alloys limited, G. hopwood & sons limited, e s honey limited and texas demolitions limited to yorkshire bank PLC.
    Kurze Angaben
    2 acre street, denton all fixtures and fittings (other than trade fixtures & fittings) plant & machinery floating charge over all movable plant machinery and equipment. (Fixtures & fitting, materials & articles.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    • 24. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 24. Nov. 1981
    Geliefert am 27. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 acre street denton manchester title no. Ln 267300.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Limited
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 10. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0