TEXAS HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TEXAS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01116472 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TEXAS HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oaklands 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TEXAS GROUP PLC | 13. Apr. 1989 | 13. Apr. 1989 |
TEXAS GROUP OF COMPANIES LIMITED | 14. Jan. 1987 | 14. Jan. 1987 |
TEXAS METAL INDUSTRIES LIMITED | 04. Juni 1973 | 04. Juni 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Nov. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Aug. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 19. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2023 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2022 | 8 Seiten | AA | ||
Change of details for Mr Michael Anthony Mcdonald as a person with significant control on 05. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Barton Hall Hardy Street Eccles Manchester M30 7NB zum Oaklands 68 Crofts Bank Road Urmston Manchester M41 0UH am 15. Mai 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2021 | 9 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Mark Mcdonald am 21. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart James Mollekin am 15. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Kean Mcdonald am 15. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Jones am 15. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2018 | 17 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 18 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 28 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 25 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 27 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 22 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLLEKIN, Stuart James | Sekretär | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | British | 36939710003 | ||||||
JONES, Thomas | Geschäftsführer | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | England | British | Solicitor | 9001390002 | ||||
MCDONALD, James Mark | Geschäftsführer | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | England | British | Company Director | 89192180003 | ||||
MCDONALD, Robert Kean | Geschäftsführer | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | England | British | Company Director | 45512800002 | ||||
MOLLEKIN, Stuart James | Geschäftsführer | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | England | British | Accountant | 36939710004 | ||||
MCDONALD, Pauline | Sekretär | Hobb Hill Farm Hague Street Whitfield SK13 8NS Glossop Derbyshire | British | 35616300001 | ||||||
MITCHELMORE, Gayle Sonia | Sekretär | 22 Chestnut Avenue Cadishead M44 5ZG Manchester | British | Financial Controller | 91477350001 | |||||
WORSLEY, David | Sekretär | Grimeford Farm Anderton PR6 9HP Chorley Lancashire | British | Financial Director | 14768640003 | |||||
GREEN, Charles Alexander | Geschäftsführer | Oak Tree Farm Blankney Barff LN4 3BJ Wetheringham Lincolnshire | British | Director | 75952680002 | |||||
HEYWOOD, Maria Theresa | Geschäftsführer | 63 Denton Road Audenshaw M34 5BL Manchester Lancashire | British | Secretary | 7350640001 | |||||
MANNING, Paul Hurton | Geschäftsführer | 4 Fawns Keep Mottram Rise SK15 2UL Stalybridge Cheshire | England | British | Director | 54192630001 | ||||
MCDONALD, Anthony Michael | Geschäftsführer | Glenwood Cottage 25 Andrew Lane High Lane SK6 8HX Stockport Cheshire | British | Company Director | 51141710003 | |||||
MCDONALD, Terence | Geschäftsführer | 21 Wheatfield SK15 2TZ Stalybridge Cheshire | British | Metal Merchant | 7350660001 | |||||
POMFRET, Adrian Philip | Geschäftsführer | 2 Langdale Close Denton M34 6JU Tameside Manchester | British | Manager | 54315100001 | |||||
TURNBULL, Laurence Andrew | Geschäftsführer | Penarwel House Llanbedrog LL55 7NN Pwllheli Gwynedd Wales | Wales | British | Consultant | 38480910001 | ||||
WILLMOTT, Brian John | Geschäftsführer | 6 Westmoreland Close PE8 6QR Peterborough Cambridgeshire | British | Director | 92725860001 | |||||
WORSLEY, David | Geschäftsführer | Grimeford Farm Anderton PR6 9HP Chorley Lancashire | British | Financial Director | 14768640003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TEXAS HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Anthony Michael Mcdonald | 05. Mai 2017 | 68 Crofts Bank Road Urmston M41 0UH Manchester Oaklands England | Nein |
Nationalität: Belgian Staatsangehörigkeit: Belgium | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat TEXAS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 27. Mai 2011 Geliefert am 04. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 12. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £500,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First floating charge of all assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 22. Nov. 2004 Geliefert am 26. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 63097842 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 06. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Aug. 1999 Geliefert am 19. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Exact house 10 whitacre road nuneaton warwickshire t/no: WK344857. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Aug. 1999 Geliefert am 19. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings on the north side of cut lane derby in the county of derbyshire t/no: DY156519. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1998 Geliefert am 06. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a exact house,10 whiteacre road,nuneaton,warwickshire.t/no.WK344857.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Sub-mortgage | Erstellt am 26. Sept. 1996 Geliefert am 02. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies secured by the legal charge dated 12TH september 1996 and all benefits and moneys therein contained. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Feb. 1996 Geliefert am 27. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 whitacre road, nuneaton t/no: WK344857. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 1995 Geliefert am 31. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and buildings on the east side of oldham st,denton,tameside,gt.manchester known as tate pipeline building; t/no.gm 312627 with all fixtures/fittings,plant,machinery......etc.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Jan. 1994 Geliefert am 22. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (or any company controlled by the company or by and associated,subsidiary or parent company of the company) to bass brewers limited or to any associated,subsidiary or parent company of bass on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage and fixed charge all the property k/a the hyde botanical and horticultural club manchester road hyde cheshire (as defined in the legal charge ) by way of lfoating charge all that equipment and the stock-in-trade (as defined in the legal charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 20. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever,but limited to the company's liability under their GUA0ANTEE to beevor foundry limited of even date | |
Kurze Angaben Details of charged account(s) barclays bank PLC re texas group PLC pursuant to their guarantee in favour of beevor foundry limited dated 31 december 1993 high interest business acccount number 20003786. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 22. Dez. 1993 Geliefert am 30. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies at any time standing to the credit of a bank account presentlynumbered 20053296 with the bank in the mname of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. Aug. 1993 Geliefert am 03. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By legal mortgage freehold property known as the duke of sussex victoria street newton hyde greater manchester title no. GM520231. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. Aug. 1993 Geliefert am 03. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage freehold property known as the oddfellows arms moorend road mellor marple greater manchester title no.GM526755. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. Aug. 1993 Geliefert am 03. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the freehold property known as the beehive hague street whitfield glossop derbyshire title no. DY193716. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Juli 1992 Geliefert am 13. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the admiral rodney hotel and 10 and 12 north st,horncastle east lindsey county of lincolnshire t/n LL474941 including all fixtures and fittings see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juni 1992 Geliefert am 17. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a talk of the north, liverpool road, eccles in the city of manchester t/no: gm 272264 including all fixtures & fittings (otherthan trade fixtures & fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Juni 1992 Geliefert am 17. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property fronting to liverpool road,eccles in the county of greater manchester together with the buildings k/a the airport hotel including all fixtures & fittings (other than trade fixtures & fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 09. Aug. 1991 Geliefert am 14. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H beevor foundry beevor street lincoln floating charge over all movable plant machinery and equipment. (Please see doc for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge. | Erstellt am 22. Apr. 1988 Geliefert am 29. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of a bank account (presently numbered 05001954) with the bank in the name of the company (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Nov. 1987 Geliefert am 01. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or texas metal industries limited and/or T.M.I. (metals) limited and/or G. hopwood & sons limited and/or E.S. honey limited and/or texas demolitions limited to yorkshire bank PLC under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Okt. 1987 Geliefert am 22. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from texas metal industries limited and/or texas alloys limited and/or E.S. honey limited and/or T.M.I. (metals) limited and/or texas demolitions limited to yorkshire bank PLC on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Gatefield works whitelands road ashton under lyne all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant & machinery. Floating charge over all plant machinery and equipment materials & articles. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Aug. 1987 Geliefert am 12. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from texas metal industries limited, T.M.I. (metals) limited, texas alloys limited, G. hopwood & sons limited, e s honey limited and texas demolitions limited to yorkshire bank PLC. | |
Kurze Angaben 2 acre street, denton all fixtures and fittings (other than trade fixtures & fittings) plant & machinery floating charge over all movable plant machinery and equipment. (Fixtures & fitting, materials & articles. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 24. Nov. 1981 Geliefert am 27. Nov. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 acre street denton manchester title no. Ln 267300. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0