ANVIL PLANT HIRE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANVIL PLANT HIRE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01119127
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANVIL PLANT HIRE LIMITED?

    • (4550) /

    Wo befindet sich ANVIL PLANT HIRE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Wilson Pitts
    Glendevon House
    LS41 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANVIL PLANT HIRE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANVIL PLANT HIRE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juni 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von ANVIL PLANT HIRE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SYMON, David Alistair
    Pooh Cottage
    Wolley
    WF4 2JZ Wakefield
    Geschäftsführer
    Pooh Cottage
    Wolley
    WF4 2JZ Wakefield
    British81325210003
    DOUGLAS, Robert Granville
    The Shottery
    39 Four Oaks Road
    B74 2XU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    The Shottery
    39 Four Oaks Road
    B74 2XU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British10466920001
    FLETCHER, Christine Barbara
    97 Beech Drive
    TF11 8HZ Shifnal
    Shropshire
    Sekretär
    97 Beech Drive
    TF11 8HZ Shifnal
    Shropshire
    British91298830001
    LAWTON, Christopher Erskine
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Sekretär
    22 Church Fields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British44540640001
    LETHABY, Michael Richard
    Shepherds Cottage
    Heaverham Road Kemsing
    TN15 6NG Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    Shepherds Cottage
    Heaverham Road Kemsing
    TN15 6NG Sevenoaks
    Kent
    British49511390006
    MARTIN, Brian Laurence
    22 Churchfields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    Sekretär
    22 Churchfields
    ME19 6RJ West Malling
    Kent
    British7979620002
    PEMBLE, Clifford Lester
    96a Marshall Road
    Rainham
    ME8 0AN Gillingham
    Kent
    Sekretär
    96a Marshall Road
    Rainham
    ME8 0AN Gillingham
    Kent
    British5734200002
    WALL, Graeme Anthony
    The Old Rectory
    Church Lane Nackington
    CT4 7AD Canterbury
    Kent
    Sekretär
    The Old Rectory
    Church Lane Nackington
    CT4 7AD Canterbury
    Kent
    British75687220001
    BROOKE, Richard John Russell
    Ivanhoe House
    Main Street Smisby
    LE65 2TY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Ivanhoe House
    Main Street Smisby
    LE65 2TY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    United KingdomBritish52648130001
    BROWN, Graham Marshall
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish9631280002
    GAIR, William Cortis
    Russell Court
    60 Russell Hill Road
    CR8 2LB Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Russell Court
    60 Russell Hill Road
    CR8 2LB Purley
    Surrey
    United KingdomBritish35531770001
    GILHAM, Paul John
    25 The Green
    Darenth Village Park
    DA2 6JS Dartford
    Geschäftsführer
    25 The Green
    Darenth Village Park
    DA2 6JS Dartford
    EnglandBritish55394020002
    HOLLIDAY, Peter David
    Dundry
    Water End Road Potten End
    HP4 2SG Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Dundry
    Water End Road Potten End
    HP4 2SG Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish78225380002
    HOLLIDAY, Peter David
    Dundry
    Water End Road Potten End
    HP4 2SG Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Dundry
    Water End Road Potten End
    HP4 2SG Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish78225380002
    LETHABY, Michael Richard
    Shepherds Cottage
    Heaverham Road Kemsing
    TN15 6NG Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Shepherds Cottage
    Heaverham Road Kemsing
    TN15 6NG Sevenoaks
    Kent
    British49511390006
    MAY, George William
    2 Coggers Cottages
    The Broadway Lamberhurst
    TN3 8DA Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Coggers Cottages
    The Broadway Lamberhurst
    TN3 8DA Tunbridge Wells
    Kent
    British16889970002
    PEAD, David William
    Muretto 36 Mays Hill Road Shortlands
    BR2 0HT Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    Muretto 36 Mays Hill Road Shortlands
    BR2 0HT Bromley
    Kent
    British7979630001
    PRICE, Keith
    P4 Ludgate Loft Apartments
    Ludgate Hill
    B3 1DW Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    P4 Ludgate Loft Apartments
    Ludgate Hill
    B3 1DW Birmingham
    West Midlands
    British65559690001
    ROBERTSON, Ian
    4 Serpentine Close
    St James Park Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Serpentine Close
    St James Park Radcliffe On Trent
    NG12 2NS Nottingham
    Nottinghamshire
    British75530390001
    SAVILLE, Patrick Barry
    53 Dornden Drive
    Langton Green
    TN3 0AE Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    53 Dornden Drive
    Langton Green
    TN3 0AE Tunbridge Wells
    Kent
    British16889960001
    STANSFIELD, Michael John
    5 The Coppice
    LE10 2TF Burbage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    5 The Coppice
    LE10 2TF Burbage
    Leicestershire
    United KingdomBritish106606260001
    STEELE, David John Curtis
    40 Syke Cluan
    SL0 9EJ Iver
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    40 Syke Cluan
    SL0 9EJ Iver
    Buckinghamshire
    British47200950001
    TOWNSEND, Nicolas John
    Carrygate
    Back Lane
    LE7 9LP Gaulby
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Carrygate
    Back Lane
    LE7 9LP Gaulby
    Leicestershire
    EnglandBritish41603000002
    WARD, Dennis John
    Burwell Grange
    Hartlip
    ME9 7TJ Sittingbourne
    Kent
    Geschäftsführer
    Burwell Grange
    Hartlip
    ME9 7TJ Sittingbourne
    Kent
    British41004700001
    WILLIAMS, James Michael
    Corner Cottage
    23 The Green Edlesborough
    LU6 2JF Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Corner Cottage
    23 The Green Edlesborough
    LU6 2JF Dunstable
    Bedfordshire
    British4214040001

    Hat ANVIL PLANT HIRE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Juli 2002
    Geliefert am 27. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and for Each of the Securedparties
    Transaktionen
    • 27. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental debenture made between the company ward holdings limited ward homes limited castle village investments limited castle village limited wards construction (investments) limited ward homes (south eastern) limited ward homes (london) limited wards construction (industrial) limited ward homes (anglia) limited and the security trustee
    Erstellt am 27. Okt. 2000
    Geliefert am 10. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a composite guarantee and debenture dated 24TH july 2000 between the parties hereto and amended (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) on Behalf of Itself and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Secured Documents
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 2000
    Geliefert am 10. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to "the secured documemnts" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC ("the Security Trustee") on Behalf of Itself and the Banks and Financial Institutions from Time to Time Partiesto the Secured Documents
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 27. Mai 1994
    Geliefert am 16. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 27. Mai 1994
    Geliefert am 16. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 11. Feb. 1974
    Geliefert am 21. Feb. 1974
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or from any other person, company firm (upon the security in the latter case of any guarantee created in favour of the bank and to which the company is party whether such guarantee is already existing or is created at any time time hereafter
    Kurze Angaben
    (See doc 7). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1974Registrierung einer Belastung
    • 09. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ANVIL PLANT HIRE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Dez. 2005Beginn der Liquidation
    12. Apr. 2010Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Praktiker
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Julian Pitts
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS1 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Praktiker
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS1 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0