ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01129454 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC | 16. Aug. 1973 | 16. Aug. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 011294540025 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 011294540026 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angus Alexander Dodd als Geschäftsführer am 07. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Apr. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875630001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Sekretär | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Sekretär | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| GIBSON, Timothy David | Sekretär | 52a Grenville Road N19 4EH London | British | 50070710001 | ||||||
| HUGHES, Paul | Sekretär | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Sekretär | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104150001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 17 Field Close Locks Heath SO31 6TX Southampton Hampshire | British | 58498140001 | ||||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Sekretär | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Sekretär | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| AL-SAGER, Mohammed Jassem | Geschäftsführer | Dahiyat Abdullah Al Salem Area 4 Street No 43 Viilla 24 FOREIGN Kuwait City Kuwaiti | British | 36413770001 | ||||||
| ARRA, Giorgio | Geschäftsführer | 26 Hereford House 66 North Row W1R 1DE London | Italian | 71142090001 | ||||||
| BROOKER, Alfred Thomas | Geschäftsführer | Crispin The Approach, Dormans Park RH19 3NU East Grinstead West Sussex | England | British | 29444930001 | |||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| CLARK, James Robert | Geschäftsführer | Logmore 37 The Avenue SM2 7QA Cheam Surrey | United Kingdom | British | 52063220001 | |||||
| DEAR, Michael Raymond | Geschäftsführer | 16 Calvin Close GU15 1DN Camberley Surrey | British | 11171470001 | ||||||
| DODD, Angus Alexander | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Geschäftsführer | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Geschäftsführer | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Geschäftsführer | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Geschäftsführer | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Geschäftsführer | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| HOOPER, Patrick Paul | Geschäftsführer | Thornfield 92 Station Road Balsall Common CV7 7FL Coventry West Midlands | British | 455570001 | ||||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| KATZ, Jonathan | Geschäftsführer | 60 Mount Ephraim Lane SW16 1JD London | England | British | 33805490001 | |||||
| KNIGHT, Eric | Geschäftsführer | 7 Boulevard Des Moulins MC9800 Monaco | Italian | 55114600003 | ||||||
| LAZARUS, James Nicholas | Geschäftsführer | Misbourne 47 Foxdell Way Chalfont St Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 8315580001 | |||||
| PARRY, John Richard | Geschäftsführer | High Barn The Paddocks Dog Kennel Lane WD3 5EE Chorleywood Hertfordshire | British | 2995850001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Geschäftsführer | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Geschäftsführer | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Geschäftsführer | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintain Limited | 06. Apr. 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2017 Geliefert am 07. Nov. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 15. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge security agreement | Erstellt am 14. März 2008 Geliefert am 17. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 04. Feb. 2008 Geliefert am 15. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 07. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 01. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 25. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 26. Okt. 2005 Geliefert am 11. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 26. Okt. 2005 Geliefert am 11. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage by way of assignment | Erstellt am 03. März 2000 Geliefert am 09. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999 | |
Kurze Angaben All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. März 1999 Geliefert am 30. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 11. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1998 Geliefert am 08. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Jan. 1998 Geliefert am 17. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Feb. 1996 Geliefert am 20. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Shares charge | Erstellt am 23. Jan. 1995 Geliefert am 31. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge | |
Kurze Angaben 100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 06. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 77 st john street, london EC1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Apr. 1989 Geliefert am 14. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Apr. 1989 Geliefert am 14. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Juli 1988 Geliefert am 13. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1988 Geliefert am 12. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 28/30 coppergate york north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1988 Geliefert am 12. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1988 Geliefert am 12. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1988 Geliefert am 12. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1988 Geliefert am 12. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0