HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01129675 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
- (2875) /
Wo befindet sich HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Halesfield 4 Telford TF7 4AP Salop |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BOSTWICK INTERNATIONAL LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
FAYLONG LIMITED | 17. Aug. 1973 | 17. Aug. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Nigel Homer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Nigel Homer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Ratcliffe als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrews als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrews als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMER, Nigel | Sekretär | Halesfield 4 Telford TF7 4AP Salop | 153564400001 | |||||||
HOMER, Nigel | Sekretär | Halesfield 4 Telford TF7 4AP Salop | 153117000001 | |||||||
FARBER, Peter | Geschäftsführer | Huntsmans Close WV16 5BE Bridgnorth 13 Shropshire United Kingdom | England | Swiss | Director And Economist | 107121150002 | ||||
ANDREWS, Paul | Sekretär | 15 The Knotches Seifton Batch SY7 9LQ Craven Arms Shropshire | British | Financial Director | 111433100002 | |||||
BRINDLEY, Peter Henry | Sekretär | 1 Albany Close West Bergholt CO6 3LE Colchester Essex | British | 11552730001 | ||||||
FARMER, Owen Michael | Sekretär | 17 Kingsclear Park GU15 2LS Camberley Surrey | British | Director | 57247560001 | |||||
KEABLE, Alan James | Sekretär | 1 Heron Avenue SK16 5QB Dukinfield Cheshire | British | 53512330001 | ||||||
MCGARRY, Stephen | Sekretär | 5 Ashurst Drive S6 5LL Sheffield South Yorkshire | British | Finance Director | 43205150001 | |||||
NEATH, Kerry Daniel | Sekretär | 71 Conway Drive Shepshed LE12 9PP Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 35102000002 | |||||
RATCLIFFE, David Morley | Sekretär | 3 Woodberry Avenue North Harrow HA2 6AU Harrow Middlesex | British | 15520590001 | ||||||
ANDREWS, Paul | Geschäftsführer | 15 The Knotches Seifton Batch SY7 9LQ Craven Arms Shropshire | England | British | Financial Director | 111433100002 | ||||
DAVIES, David | Geschäftsführer | Ribendell 39 Woodlands Drive CW4 8JH Goostrey Cheshire | British | Director | 72615990001 | |||||
DE MARGARY, Bridget Joanna Maria Margaret | Geschäftsführer | 33 Clapham Common Northside SW4 0RW London | England | British | Company Director | 1380360002 | ||||
FARMER, Owen Michael | Geschäftsführer | 17 Kingsclear Park GU15 2LS Camberley Surrey | England | British | Director | 57247560001 | ||||
HALL, David Graham | Geschäftsführer | Hook Farm Bunce Common Road RH2 8NS Leigh Surrey | England | British | Company Director | 95446610001 | ||||
HOLLOWAY, David John | Geschäftsführer | 25 Edgar Road St Cross SO23 9TN Winchester Hampshire | England | British | Company Director | 66183100001 | ||||
IRWIN, John David | Geschäftsführer | Seeleys Orchard 39 Penn Road HP9 2LN Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Director | 59361420001 | ||||
JACQUES, Anthony | Geschäftsführer | 51 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | Company Director | 24972030001 | |||||
JOWICZ, John Peter | Geschäftsführer | 5 Rushes Mill Foxglove Meadows Pelsall WS3 4QU Walsall West Midlands | British | Finance Director | 74250200001 | |||||
MARTIN, David Ernest | Geschäftsführer | 20 St Johns Crescent CM24 8JT Stansted Essex | British | Company Director | 31053760001 | |||||
MCGARRY, Stephen | Geschäftsführer | 5 Ashurst Drive S6 5LL Sheffield South Yorkshire | British | Finance Director | 43205150001 | |||||
NEATH, Kerry Daniel | Geschäftsführer | 71 Conway Drive Shepshed LE12 9PP Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 35102000002 | |||||
PEARSON, John Christopher | Geschäftsführer | 58 Millford Avenue Urmston M41 6JZ Manchester Lancashire | British | Company Director | 20587330001 | |||||
ROGERS, David | Geschäftsführer | Rose Cottage Church Eaton ST20 0AX Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Accountant | 34813700001 | ||||
SENIOR, Ronald George | Geschäftsführer | Stable Lodge Church Lane Pavenham MK43 7PU Bedford Bedfordshire | British | Director | 6893660001 | |||||
SWALLOW, Jake Brangwyn Sheridan | Geschäftsführer | Brickhill House North Oakley RG26 5TT Tadley Hampshire | England | British | Company Director | 1483180001 |
Hat HENDERSON-BOSTWICK INDUSTRIAL DOORS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture between the chargor kaba holdings ag as the parent and the security agent | Erstellt am 09. Apr. 2001 Geliefert am 20. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due owing or incurred to the secured parties (or any of them) (as defined) by the obligors (as defined) under the finance documents (or any of them) (as defined) on any account whatsoever pursuant to any of the finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 08. Juli 1999 Geliefert am 15. Juli 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £3,500.00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/Hold premises - wharf rd,pinxton,bolsover,derbyshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £36,500.00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/Hold premises - somercotes grange close,clover nook industrial estate,normanton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £36,500.00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/Hold premises known as bletchley rd,stockport,gt.manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Feb. 1994 Geliefert am 19. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0