CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED

CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCITY & THAMES PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01130323
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o C/O THRINGS LLP
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SOUTH THAMES PROPERTIES LIMITED 15. Okt. 199315. Okt. 1993
    E.W.A. SECURITIES LIMITED21. Aug. 197321. Aug. 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Dez. 2015 bis 28. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2015 bis 29. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ewa Maria Lewis am 15. Sept. 2015

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Meredith Lewis am 15. Sept. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2014 bis 30. Dez. 2014

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2013 bis 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2012 bis 28. Feb. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Thring Townsend Kinnaird House 1 Pall Mall East London SW1Y 5AU* am 16. Jan. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2009

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEWIS, Ewa Maria
    Horn Lane
    Evenlode
    GL56 0NT Moreton-In-Marsh
    The Old Forge
    Gloucestershire
    England
    Sekretär
    Horn Lane
    Evenlode
    GL56 0NT Moreton-In-Marsh
    The Old Forge
    Gloucestershire
    England
    British33321140004
    LEWIS, Anthony Meredith
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    14
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish42617910002
    CODY, Nicholas John
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y ODX Blackfriars
    London
    Sekretär
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y ODX Blackfriars
    London
    British1611240001
    HAND, Stephen Brian
    61 Chigwell Park Drive
    IG7 5AZ Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    61 Chigwell Park Drive
    IG7 5AZ Chigwell
    Essex
    British52239970002
    LEWIS, Alexander Edward Meredith
    Hampnett House
    Northleach
    GL54 3NN Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Hampnett House
    Northleach
    GL54 3NN Cheltenham
    Gloucestershire
    British85515130001
    LEWIS, Ewa Maria Anna
    C/O Taylor Joynson Garrett
    10 Maltravers Street
    WC2R 3BS London
    Geschäftsführer
    C/O Taylor Joynson Garrett
    10 Maltravers Street
    WC2R 3BS London
    British33321140002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Anthony Meredith Lewis
    c/o C/O THRINGS LLP
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Kinnaird House
    06. Apr. 2016
    c/o C/O THRINGS LLP
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Kinnaird House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over shares
    Erstellt am 14. Jan. 2004
    Geliefert am 21. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and any right title & interest which the company holds in one ordinary share of £1 in the share capital of city & thames (fetter lane) limited including any other stocks, shares, securities or property, the proeceeds of sale of the securities and all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2003
    Geliefert am 03. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    St clements house bell lane spitalfields stepney london tower hamlets t/n LN95726. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2003
    Geliefert am 03. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1999
    Geliefert am 14. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 4-10 (formerly k/a 4-8 (even numbers) leyden street 11-19 (odd numbers) cobb street and 9-17 (odd numbers) bell lane london E1 t/no LN95726. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1999
    Geliefert am 14. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 33 and 35 baylis road lambeth t/no SGL372830 & LN227408. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 1997
    Geliefert am 29. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Restriction on charges and disposals:- the company may not without the previous written consent of the bank create or attempt to create any mortgage charge or encumbrance on any freehold or leasehold property of the company or any other asset subject to a fixed charge under the debenture nor in any way dispose of the equity of redemption thereof or any interest therein. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,144,250 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    27 minories london EC3.
    Berechtigte Personen
    • The Trustees of the Scb Pension Scheme
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1995
    Geliefert am 15. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land k/as 337 kennington lane.t/no.SGL286005 together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon held or owned by the company please see ch microfiche for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Juni 1994
    Geliefert am 04. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 337 kennington lane t/no: SGL286005 .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Dez. 1987
    Geliefert am 10. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 denbigh terrace london W11 T.N. 458615 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1982
    Geliefert am 22. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 31 cumberland street, parts 31 clarenden street, london SW1. Title no. Ngl 61616 & 123039.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co. (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1981
    Geliefert am 15. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises situate at & known as:- 103 & 105 alderley street in the city of westminster.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1976
    Geliefert am 02. Nov. 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    13 redcliffe street london SW10. Title no ln 167373. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1976Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 1976
    Geliefert am 25. Okt. 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as 24 clivden place london SW1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1976Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Aug. 2016Antragsdatum
    20. Juni 2018Abschluss der Liquidation
    06. Feb. 2017Beginn der Liquidation
    06. Apr. 2023Soll aufgelöst werden am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0