CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01130323 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o C/O THRINGS LLP Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SOUTH THAMES PROPERTIES LIMITED | 15. Okt. 1993 | 15. Okt. 1993 |
| E.W.A. SECURITIES LIMITED | 21. Aug. 1973 | 21. Aug. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Auflösungsaufschub | 1 Seiten | L64.04 | ||||||||||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Dez. 2015 bis 28. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2015 bis 29. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ewa Maria Lewis am 15. Sept. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Meredith Lewis am 15. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2014 bis 30. Dez. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2013 bis 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2012 bis 28. Feb. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Thring Townsend Kinnaird House 1 Pall Mall East London SW1Y 5AU* am 16. Jan. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Ewa Maria | Sekretär | Horn Lane Evenlode GL56 0NT Moreton-In-Marsh The Old Forge Gloucestershire England | British | 33321140004 | ||||||
| LEWIS, Anthony Meredith | Geschäftsführer | Ovington Street SW3 2JB London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 42617910002 | |||||
| CODY, Nicholas John | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment EC4Y ODX Blackfriars London | British | 1611240001 | ||||||
| HAND, Stephen Brian | Geschäftsführer | 61 Chigwell Park Drive IG7 5AZ Chigwell Essex | British | 52239970002 | ||||||
| LEWIS, Alexander Edward Meredith | Geschäftsführer | Hampnett House Northleach GL54 3NN Cheltenham Gloucestershire | British | 85515130001 | ||||||
| LEWIS, Ewa Maria Anna | Geschäftsführer | C/O Taylor Joynson Garrett 10 Maltravers Street WC2R 3BS London | British | 33321140002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Anthony Meredith Lewis | 06. Apr. 2016 | c/o C/O THRINGS LLP 1 Pall Mall East SW1Y 5AU London Kinnaird House | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Erstellt am 14. Jan. 2004 Geliefert am 21. Jan. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and any right title & interest which the company holds in one ordinary share of £1 in the share capital of city & thames (fetter lane) limited including any other stocks, shares, securities or property, the proeceeds of sale of the securities and all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben St clements house bell lane spitalfields stepney london tower hamlets t/n LN95726. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1999 Geliefert am 14. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 4-10 (formerly k/a 4-8 (even numbers) leyden street 11-19 (odd numbers) cobb street and 9-17 (odd numbers) bell lane london E1 t/no LN95726. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1999 Geliefert am 14. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 33 and 35 baylis road lambeth t/no SGL372830 & LN227408. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Okt. 1997 Geliefert am 29. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Restriction on charges and disposals:- the company may not without the previous written consent of the bank create or attempt to create any mortgage charge or encumbrance on any freehold or leasehold property of the company or any other asset subject to a fixed charge under the debenture nor in any way dispose of the equity of redemption thereof or any interest therein. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Apr. 1997 Geliefert am 07. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,144,250 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 27 minories london EC3. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Dez. 1995 Geliefert am 15. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land k/as 337 kennington lane.t/no.SGL286005 together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon held or owned by the company please see ch microfiche for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juni 1994 Geliefert am 04. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a 337 kennington lane t/no: SGL286005 .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Dez. 1987 Geliefert am 10. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18 denbigh terrace london W11 T.N. 458615 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1982 Geliefert am 22. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 31 cumberland street, parts 31 clarenden street, london SW1. Title no. Ngl 61616 & 123039. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Apr. 1981 Geliefert am 15. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises situate at & known as:- 103 & 105 alderley street in the city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1976 Geliefert am 02. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 13 redcliffe street london SW10. Title no ln 167373. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Okt. 1976 Geliefert am 25. Okt. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as 24 clivden place london SW1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0