P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01131488 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 20. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 28. Sept. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Juli 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Deborah Grimason am 13. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 21. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| HARRIS, Jane Gwendoline | Sekretär | Tithe Farm Barton Road Congerstone CV13 6NB Nuneaton Warks | British | 13905760001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| RICHARDSON, Barbara Jane | Sekretär | 8 Wide Street Hathern LE12 5JH Loughborough Leicestershire | British | 48223350001 | ||||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| ELLIOT, Colin Richard | Geschäftsführer | 3 Meadow Crescent Castle Donington DE74 2LX Derby Derbyshire | British | 13905780002 | ||||||||||
| GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HARRIS, Jane Gwendoline | Geschäftsführer | Tithe Farm Barton Road Congerstone CV13 6NB Nuneaton Warks | British | 13905760001 | ||||||||||
| HARRIS, Peter Christopher Peile | Geschäftsführer | Tithe Farm Barton Road Congerstone CV13 6NB Nuneaton Warks | United Kingdom | British | 13905790002 | |||||||||
| MCKAY, Francis John | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | 78787530001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Barbara Jane | Geschäftsführer | 8 Wide Street Hathern LE12 5JH Loughborough Leicestershire | British | 48223350001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Peter David | Geschäftsführer | 8 Wide Street Hathern LE12 5JH Loughborough Leicestershire | British | 13905770002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C.P. Harris (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 22. Dez. 1998 Geliefert am 05. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Aug. 1989 Geliefert am 07. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property units 5 & 6 old station close, shepshed. Title no lt 124595 by way of equitable charge all moneys received of any insurance in respect of loss or damage by fire or otherwide to the buildings or any part being subject to the security. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Apr. 1989 Geliefert am 05. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1986 Geliefert am 04. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over piece of land situate & having a frontage to trent lane, castle donington leics., Containing an area of 1.76 acres or thereabouts, together with all buildings fixtures fixed plant & machinery. All other l/h & f/h property together with buildings fixtures fixed plant & machinery. Goodwill, uncalled capital book & other debts. Floating charge over stock-on-trade, work-in-progress, pre payments investments all other undertaking & property & assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 1985 Geliefert am 10. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Dez. 1982 Geliefert am 13. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H units 5 & 6 old station close shepshed leicestershire by way of equi table charge all moneys received of any insurance whatsoever in respect of loss or damage by fire or otherwise to the buildings or any part thereof being subject to the security. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Nov. 1979 Geliefert am 07. Nov. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage upon plot 5B old station close, shepshed, leics together with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0