TP SHELFCO NO.3 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TP SHELFCO NO.3 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01132499 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BIRCHWOOD PRODUCTS LIMITED | 04. Dez. 1996 | 04. Dez. 1996 |
J.B. SIMONS LIMITED | 04. Sept. 1973 | 04. Sept. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 29. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Juli 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 18. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 18. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 11. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 137582690004 | ||||||||
TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
BALL, Ute Suse | Sekretär | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | British | 118371550001 | ||||||||||
BOLLU, Pierre | Sekretär | 20 Lime Grove Avenue NG9 4AR Chilwell Nottinghamshire | British | Accountant | 92317380001 | |||||||||
PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | 158161020001 | |||||||||||
SIMONS, John Barry | Sekretär | 28 Bromyard Terrace St Johns WR2 5BW Worcester Worcestershire | British | 94492900001 | ||||||||||
SIMONS, Pamela Helen | Sekretär | 12 Delville Avenue Keyworth NG12 5JA Nottingham Nottinghamshire | British | 26705640001 | ||||||||||
SMITH, Anthony Edward | Sekretär | 278 Heanor Road DE7 8TG Ilkeston Derbyshire | British | Manager | 36984820003 | |||||||||
BELL, Norman | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 106766000001 | ||||||||
BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | Company Director | 178011680002 | ||||||||
BURTON, Alan | Geschäftsführer | Beck House Hawthorn Close NG14 7HW Bleasby Nottinghamshire | British | Director | 79640650001 | |||||||||
CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 46226920007 | ||||||||
COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 104472550001 | ||||||||
GREATOREX, Sue | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 177194840001 | ||||||||
GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | Company Secretary | 185755960002 | ||||||||
HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72135950007 | ||||||||
KAVANAGH, Carol | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Hr Director | 127248260001 | ||||||||
MEECH, Martin Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 108246880001 | ||||||||
MURRAY, John Roderick | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | Director | 145111310001 | ||||||||
OOSTEN, Jean-Jacques Michel Van | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | Belgian | Company Director | 177926250001 | ||||||||
PROCTOR, Robin David | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 117945650001 | ||||||||
SIMONS, John Barry | Geschäftsführer | 28 Bromyard Terrace St Johns WR2 5BW Worcester Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 94492900001 | ||||||||
SIMPSON, Paul Anthony | Geschäftsführer | Field Farm Ember Lane Langham Road Langham LN13 9SL Mumby Lincolnshire | United Kingdom | British | Sales Director | 198094060001 | ||||||||
SKELTON, Steven Donald | Geschäftsführer | 4 Conniston Close SL7 2RG Marlow Buckinghamshire | British | Accountant | 7330680001 | |||||||||
SLARK, Gavin | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | Director | 162972090001 | ||||||||
SMITH, Anthony Edward | Geschäftsführer | Bonita House 11 Risborrow Close DE65 6HY Etwall Derbyshire | United Kingdom | British | Managing Director | 36984820004 | ||||||||
SWANWICK, Paul | Geschäftsführer | 59 Maple Avenue Beeston Rylands NG9 1PU Nottingham Nottinghamshire | British | Purchasing Manager | 60218470001 | |||||||||
TALLENTIRE, Paul John | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House Leicestershire United Kingdom | England | British | Company Director | 134335900002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TP SHELFCO NO.3 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Perkins Financing Company No.3 Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TP SHELFCO NO.3 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 11. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 2004 Geliefert am 21. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a dg house, park lodge lane, giltbrook, nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property of the chargor situate in england and wales and all liens, charges, options, agreements, rights and interests in or over land or the proceeds of sale of land, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property or land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 11. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all other companies therein to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 11. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Unit 5 cossall industrial estate ilkeston derbyshire DE7 5UB. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1997 Geliefert am 13. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Factory premises at units 5 a, b, c & d cossall industrial estate coronation road cossall nottinghamshire t/n: NT287721. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Nov. 1996 Geliefert am 20. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 13. Nov. 1985 Geliefert am 20. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Apr. 1983 Geliefert am 10. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at brand street nottingham title no nt 66141. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Jan. 1980 Geliefert am 09. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Factory premises at castle meadow rd nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Juli 1979 Geliefert am 07. Aug. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or needham and jackson LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TP SHELFCO NO.3 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0