GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01132901 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christian Keen als Geschäftsführer am 18. Mai 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Apr. 2022 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. März 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcus Hilger als Geschäftsführer am 25. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christian Keen als Direktor am 25. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Marcus Hilger am 09. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Marcus Hilger als Direktor am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hanns Martin Lipp als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Hanns Martin Lipp als Direktor am 21. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thorsten Beer als Geschäftsführer am 21. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGG, Nichola Louise | Sekretär | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
| HALL, Wendy Margaret | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 172979860001 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Sekretär | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Sekretär | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Sekretär | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Sekretär | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Sekretär | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| SMERDON, Peter | Sekretär | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| BEER, Thorsten | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| FELLOWS, Jonathan | Geschäftsführer | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| HILGER, Marcus | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | Germany | German | 238936580003 | |||||
| HOOD, John | Geschäftsführer | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| KEEN, Christian | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 54544790004 | |||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Geschäftsführer | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| LLOYD, Allen John | Geschäftsführer | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Geschäftsführer | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| MCARDLE, John Joseph | Geschäftsführer | 20 Egginton Road Hall Green B28 0LZ Birmingham West Midlands | British | 72125670001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Geschäftsführer | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Geschäftsführer | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| STEELE, Richard John | Geschäftsführer | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | 1415570001 | |||||
| TURNER, Richard Gill | Geschäftsführer | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | 51796560002 | ||||||
| VIZARD, Ronald Charles, Harold | Geschäftsführer | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 122881190001 | ||||||
| WARD, Michael Ashley | Geschäftsführer | Flat 603 Shad Thames SE1 2YL London | England | British | 114711020001 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Chemists Limited | 06. Apr. 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 14. März 1988 Geliefert am 25. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2 mill street, congleton, cheshire. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Juli 1986 Geliefert am 31. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 339, ash bank road, werrrington, stoke on trent and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Juli 1986 Geliefert am 05. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - land & buildings fronting to trentham road, longton stoke on trent. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Juni 1986 Geliefert am 01. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 130 werrington rd, bucknall, staffs (title no sf 213244) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Mai 1986 Geliefert am 12. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 89 stafford street, hanley, stoke on trent staffordshire. Title no. Sf 126660 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1984 Geliefert am 02. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - 443 cannock road, hightown, hedensford, staffordshire title no sf 138380 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Jan. 1983 Geliefert am 27. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The pharmacy, 128 werrington road, bucknall stoke on trent. Title no sf 56195. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Mai 1982 Geliefert am 10. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 128 warrington rd. Bucknall, stoke on trent title no:- sf 56195. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Apr. 1982 Geliefert am 04. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 441 cannock road, hednesford, staffordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 1982 Geliefert am 06. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H shop and dwellinghouse at 8 bilbrook road, bilbrook tettenthall, staffordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 1978 Geliefert am 03. März 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate of interest with all f/h or l/h property all stocks shares or other securities all book and other debts assignment of goodwill floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M17). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0