MINSTERGATE HULL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMINSTERGATE HULL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01133076
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MINSTERGATE HULL LIMITED?

    • Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Großhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45310) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit B
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MINSTERGATE LTD21. Feb. 201421. Feb. 2014
    MINSTERGATE PEUGEOT (SCARBOROUGH) LTD14. Jan. 201414. Jan. 2014
    H. ARUNDALE LIMITED07. Sept. 197307. Sept. 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2024

    Welche sind die letzten Einreichungen für MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 011330760023 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 011330760024 vollständig

    1 SeitenMR04

    Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2024

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Mark Paul Campey als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Helen Jane Campey als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2024

    7 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Forster als Geschäftsführer am 12. Juli 2023

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Minstergate Livingstone Road Hessle East Yorkshire HU13 0AB zum Unit B Rotterdam Road Hull HU7 0XD am 13. März 2023

    1 SeitenAD01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2022 bis 31. März 2023

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 011330760025 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CUFF, James Howard
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Geschäftsführer
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishDirector198007350001
    BETHELL, Stephen Paul
    96 New Lane
    Huntington
    YO3 9NH York
    N Yorks
    Sekretär
    96 New Lane
    Huntington
    YO3 9NH York
    N Yorks
    British26362540001
    BOYLE, Michael Roy
    18 Bracknell Close
    SR3 2DE Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    18 Bracknell Close
    SR3 2DE Sunderland
    Tyne & Wear
    British18782760001
    MEE, Patrick Joseph
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    Sekretär
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    IrishDirector94077880002
    MOORE, Keith
    1 New Forge Court
    Towthorpe Road, Haxby
    YO32 3YA York
    North Yorkshire
    Sekretär
    1 New Forge Court
    Towthorpe Road, Haxby
    YO32 3YA York
    North Yorkshire
    BritishSecretary49217290002
    TAYLOR, David Francis
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Sekretär
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    BritishFinance Director81852670001
    ARUNDALE, James Neal
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishChairman13444300001
    BANKS, Alan Graham
    The Jays
    Parklands
    DL7 9JN Newby Wiske
    Northalllerton North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Jays
    Parklands
    DL7 9JN Newby Wiske
    Northalllerton North Yorkshire
    BritishManaging Director19296240002
    BLAIR, Richard
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishGeneral Manager125847720001
    BRIDGETT, Jean Marjorie
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishHousewife34836440002
    CAMPEY, Helen Jane
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Geschäftsführer
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director78016820003
    CAMPEY, Mark Paul
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Geschäftsführer
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director78016360002
    FORSTER, Stephen Paul
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Geschäftsführer
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    EnglandBritishCompany Director163526870001
    GIBBIN, Michael David
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director103592060001
    MEE, Patrick Joseph
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    203 St Patricks Road South
    FY8 1LG Lytham St Annes
    Lancashire
    United KingdomIrishManaging Director94077880002
    TAYLOR, David Francis
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Livingstone Road
    HU13 0AB Hessle
    Minstergate
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishFinance Director81852670002
    WATSON, Christopher
    2 Charnwood Drive
    High Grange
    DR3 0EG Darlington
    Geschäftsführer
    2 Charnwood Drive
    High Grange
    DR3 0EG Darlington
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishOps Director124667140001
    WORRALL, Timothy John
    Linden Cottage
    The Hurst Kingsley
    WA6 8BB Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Linden Cottage
    The Hurst Kingsley
    WA6 8BB Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector49048830001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MINSTERGATE HULL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Mark Paul Campey
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    06. Apr. 2016
    Rotterdam Road
    HU7 0XD Hull
    Unit B
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MINSTERGATE HULL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Seamer road, scarborough, YO12 4HW - title nyk 168017. plus all buildings, fixtures & fittings in the nature of landlords fixtures & fittings together with all rights, easements & privileges relating to or benefiting the same.. Insurances: all monies from time to time payable to the mortgagor under or pursuant to any insurances including any refund of premiums.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale LTD
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 08. März 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Dez. 2013
    Geliefert am 18. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Apr. 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Dez. 2013
    Geliefert am 11. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All that f/h property located at seamer road scarborough north yorkshire t/no NYK168017. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Apr. 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Jan. 2004
    Geliefert am 24. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or banque psa finance (the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juni 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 21. Juni 2002
    Geliefert am 26. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the leasehold property known as land lying to the south of dalby way coulby newham middlesborough title number CE118514. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 21. Juni 2002
    Geliefert am 26. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the leasehold property known as unit 3C york business park nether poppleton york title numbers NYK215329 and NYK219622. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Erstellt am 21. Juni 2002
    Geliefert am 26. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as 72-76 bessingby road bridlington title number HS67221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2002
    Geliefert am 13. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ambulance station seamer road scarborough t/n NYK168017`. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 02. Apr. 2001
    Geliefert am 05. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £62,500 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Second mortgage by care micri systems limited to the company on columbus ravine scarborough.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 10. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at great north way york business park nether poppleton york north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 09. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the agreement as set out in schedule and all premises therein; all moneys due under the agreement dated 17/8/98 relating to unit 3C,york business park,nether poppleton,north yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 22. Juli 1998
    Geliefert am 24. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in and to the insurances from time to time; floating charge over all stocks of used vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Psa Wholesale Limited
    Transaktionen
    • 24. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 1995
    Geliefert am 14. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the south of dalby way coulby newham middlesbrough cleveland t/n CE118514.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An irregular-shaped piece of land situate at the rear of victoria road and brook street scarborough north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the west side of columbus ravine and coach depot in columbus ravine scarborough north yorkshire t/no nyk 69397.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land situate in or near to stakesby road whitby north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Pieces of land in northway and brook street scarborough north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 01. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece of land in victoria road and brook street scarborough and 3 dwellinghouses and shops number 61 63 and 65 victoria road scarborough north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1989
    Geliefert am 16. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    57 & 59 victoria road scarborough north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juli 1984
    Geliefert am 03. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1982
    Geliefert am 01. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold, the garage site and premises situate and known as 72 to 76 bessingby road bridlington humberside. Title no. HS67221.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1982Registrierung einer Belastung
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Dez. 1974
    Geliefert am 16. Dez. 1974
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & bldgs in northway scarborough w yorkshire conveyance 23.8.74.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1974Registrierung einer Belastung
    • 26. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0