MINSTERGATE HULL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MINSTERGATE HULL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01133076 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MINSTERGATE HULL LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Gro ßhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45310) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich MINSTERGATE HULL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit B Rotterdam Road HU7 0XD Hull England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MINSTERGATE HULL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MINSTERGATE LTD | 21. Feb. 2014 | 21. Feb. 2014 |
MINSTERGATE PEUGEOT (SCARBOROUGH) LTD | 14. Jan. 2014 | 14. Jan. 2014 |
H. ARUNDALE LIMITED | 07. Sept. 1973 | 07. Sept. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MINSTERGATE HULL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2024 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MINSTERGATE HULL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 011330760023 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 011330760024 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2024
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Paul Campey als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Jane Campey als Geschäftsführer am 19. Apr. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2024 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2023 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Forster als Geschäftsführer am 12. Juli 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Minstergate Livingstone Road Hessle East Yorkshire HU13 0AB zum Unit B Rotterdam Road Hull HU7 0XD am 13. März 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2022 bis 31. März 2023 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 22 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 011330760025 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MINSTERGATE HULL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUFF, James Howard | Geschäftsführer | Rotterdam Road HU7 0XD Hull Unit B England | England | British | Director | 198007350001 | ||||
BETHELL, Stephen Paul | Sekretär | 96 New Lane Huntington YO3 9NH York N Yorks | British | 26362540001 | ||||||
BOYLE, Michael Roy | Sekretär | 18 Bracknell Close SR3 2DE Sunderland Tyne & Wear | British | 18782760001 | ||||||
MEE, Patrick Joseph | Sekretär | 203 St Patricks Road South FY8 1LG Lytham St Annes Lancashire | Irish | Director | 94077880002 | |||||
MOORE, Keith | Sekretär | 1 New Forge Court Towthorpe Road, Haxby YO32 3YA York North Yorkshire | British | Secretary | 49217290002 | |||||
TAYLOR, David Francis | Sekretär | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | British | Finance Director | 81852670001 | |||||
ARUNDALE, James Neal | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | England | British | Chairman | 13444300001 | ||||
BANKS, Alan Graham | Geschäftsführer | The Jays Parklands DL7 9JN Newby Wiske Northalllerton North Yorkshire | British | Managing Director | 19296240002 | |||||
BLAIR, Richard | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | England | British | General Manager | 125847720001 | ||||
BRIDGETT, Jean Marjorie | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | England | British | Housewife | 34836440002 | ||||
CAMPEY, Helen Jane | Geschäftsführer | Rotterdam Road HU7 0XD Hull Unit B England | England | British | Company Director | 78016820003 | ||||
CAMPEY, Mark Paul | Geschäftsführer | Rotterdam Road HU7 0XD Hull Unit B England | England | British | Company Director | 78016360002 | ||||
FORSTER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Rotterdam Road HU7 0XD Hull Unit B England | England | British | Company Director | 163526870001 | ||||
GIBBIN, Michael David | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | England | British | Finance Director | 103592060001 | ||||
MEE, Patrick Joseph | Geschäftsführer | 203 St Patricks Road South FY8 1LG Lytham St Annes Lancashire | United Kingdom | Irish | Managing Director | 94077880002 | ||||
TAYLOR, David Francis | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0AB Hessle Minstergate East Yorkshire England | England | British | Finance Director | 81852670002 | ||||
WATSON, Christopher | Geschäftsführer | 2 Charnwood Drive High Grange DR3 0EG Darlington | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | Ops Director | 124667140001 | ||||
WORRALL, Timothy John | Geschäftsführer | Linden Cottage The Hurst Kingsley WA6 8BB Warrington Cheshire | England | British | Director | 49048830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MINSTERGATE HULL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Mark Paul Campey | 06. Apr. 2016 | Rotterdam Road HU7 0XD Hull Unit B England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat MINSTERGATE HULL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Mai 2014 Geliefert am 02. Mai 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Seamer road, scarborough, YO12 4HW - title nyk 168017. plus all buildings, fixtures & fittings in the nature of landlords fixtures & fittings together with all rights, easements & privileges relating to or benefiting the same.. Insurances: all monies from time to time payable to the mortgagor under or pursuant to any insurances including any refund of premiums. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 06. Dez. 2013 Geliefert am 18. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 06. Dez. 2013 Geliefert am 11. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All that f/h property located at seamer road scarborough north yorkshire t/no NYK168017. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Jan. 2004 Geliefert am 24. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or banque psa finance (the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Juni 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 21. Juni 2002 Geliefert am 26. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the leasehold property known as land lying to the south of dalby way coulby newham middlesborough title number CE118514. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 21. Juni 2002 Geliefert am 26. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the leasehold property known as unit 3C york business park nether poppleton york title numbers NYK215329 and NYK219622. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge containing fixed and floating charges | Erstellt am 21. Juni 2002 Geliefert am 26. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that freehold property known as 72-76 bessingby road bridlington title number HS67221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Feb. 2002 Geliefert am 13. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a ambulance station seamer road scarborough t/n NYK168017`. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2002 Geliefert am 05. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Sub-mortgage | Erstellt am 02. Apr. 2001 Geliefert am 05. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £62,500 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Second mortgage by care micri systems limited to the company on columbus ravine scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1999 Geliefert am 10. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at great north way york business park nether poppleton york north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment | Erstellt am 09. Dez. 1998 Geliefert am 15. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the agreement as set out in schedule and all premises therein; all moneys due under the agreement dated 17/8/98 relating to unit 3C,york business park,nether poppleton,north yorkshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 22. Juli 1998 Geliefert am 24. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in and to the insurances from time to time; floating charge over all stocks of used vehicles. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Juli 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings to the south of dalby way coulby newham middlesbrough cleveland t/n CE118514. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben An irregular-shaped piece of land situate at the rear of victoria road and brook street scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the west side of columbus ravine and coach depot in columbus ravine scarborough north yorkshire t/no nyk 69397. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Piece or parcel of land situate in or near to stakesby road whitby north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Pieces of land in northway and brook street scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 01. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Piece of land in victoria road and brook street scarborough and 3 dwellinghouses and shops number 61 63 and 65 victoria road scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. März 1989 Geliefert am 16. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 57 & 59 victoria road scarborough north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Juli 1984 Geliefert am 03. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Sept. 1982 Geliefert am 01. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, the garage site and premises situate and known as 72 to 76 bessingby road bridlington humberside. Title no. HS67221. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Dez. 1974 Geliefert am 16. Dez. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & bldgs in northway scarborough w yorkshire conveyance 23.8.74. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0