MEDIGAS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMEDIGAS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01143289
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MEDIGAS LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich MEDIGAS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEDIGAS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MEDIGAS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MEDIGAS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 06. März 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Air Liquide Uk Ltd Station Road Coleshill Birmingham B46 1JY zum C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 06. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Dez. 2014

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Olivier Petit als Geschäftsführer am 03. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 253,176
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 253,176
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Reynolds als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Matthew John Hasnip als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Reynolds als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Matthew John Hasnip als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MEDIGAS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HASNIP, Matthew John
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Sekretär
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    156816780001
    VILLEPONTOUX, Sylvie
    Station Road
    Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    Air Liquide
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    Air Liquide
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomFrench152071080001
    ELLMER, Roland Charles
    33 Balderton Gate
    NG24 1UE Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    33 Balderton Gate
    NG24 1UE Newark
    Nottinghamshire
    British30251390001
    HUMBER, Paul Edmund
    The Old Vicarage
    Orleton
    SY8 4HN Ludlow
    Salop
    Sekretär
    The Old Vicarage
    Orleton
    SY8 4HN Ludlow
    Salop
    British117969160001
    MARSELLA, Gregory Edward
    1200 Skyline Drive
    Laguna Beach
    California 92651
    Usa
    Sekretär
    1200 Skyline Drive
    Laguna Beach
    California 92651
    Usa
    British30503390002
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    REYNOLDS, Andrew Joseph
    Station Road
    Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    C/O Airliquideuk Ltd
    Sekretär
    Station Road
    Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    C/O Airliquideuk Ltd
    British131613500001
    SCOREY, Michael George
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    Sekretär
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    British1749220001
    TOBITT, Nigel Derek Charles
    47 West Borough
    BH21 1LX Wimborne
    Dorset
    Sekretär
    47 West Borough
    BH21 1LX Wimborne
    Dorset
    British39085490001
    WESTWOOD, Philip John
    44 Brancaster Close
    Amington
    B77 3QD Tamworth
    Staffordshire
    Sekretär
    44 Brancaster Close
    Amington
    B77 3QD Tamworth
    Staffordshire
    British71727490001
    AITKEN, Timothy Maxwell
    26 Linda Isle
    FOREIGN Newport Beach
    California 93660
    Usa
    Geschäftsführer
    26 Linda Isle
    FOREIGN Newport Beach
    California 93660
    Usa
    British65840370002
    ASHFORD, Dennis David
    46 Brownfield Road
    Shard End
    B34 7HY Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    46 Brownfield Road
    Shard End
    B34 7HY Birmingham
    West Midlands
    British117169790001
    BATEMAN, Stephen John
    14 Avonbridge Close
    Arnold
    NG5 8DE Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    14 Avonbridge Close
    Arnold
    NG5 8DE Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish114173920001
    DELLON, Jean Baptiste
    Air Liquide Uk Ltd
    Station Road Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Air Liquide Uk Ltd
    Station Road Coleshill
    B46 1JY Birmingham
    West Midlands
    United KingdomFrench116747940001
    DEVINE, Paul Leonard
    2 Pound Close
    Langford
    SG18 9NQ Biggleswade
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    2 Pound Close
    Langford
    SG18 9NQ Biggleswade
    Bedfordshire
    British44875090001
    GRAHAM, John Michael
    1 St Georges Gardens
    Kings Road
    RH13 5PP Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    1 St Georges Gardens
    Kings Road
    RH13 5PP Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish59577090004
    GREEN, George Richard
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish4795650003
    GULLICK, Stephen Peter
    5 Slade Lane
    Homer
    TF13 6NW Much Wenlock
    Shropshire
    Geschäftsführer
    5 Slade Lane
    Homer
    TF13 6NW Much Wenlock
    Shropshire
    British46450660004
    JARRATT, William Edward
    Hunters Lodge Wick Lane
    Downton
    SP5 3NH Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Hunters Lodge Wick Lane
    Downton
    SP5 3NH Salisbury
    Wiltshire
    British9464800001
    JOHNSON, David Ian
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish46008570001
    KERNAHAN, Charles Lloyd
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    British50116330001
    LAVERY, Daniel Mark
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    British111619010001
    MOFFATT, David Stewart
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    Geschäftsführer
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    EnglandBritish88747420001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    OSMOND, William George
    Grindelwald
    Laverstock Park
    SP1 1QJ Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Grindelwald
    Laverstock Park
    SP1 1QJ Salisbury
    Wiltshire
    British28820500001
    PETIT, Olivier
    20 Rue Des Cendres
    Rueil Malmaison
    92500
    France
    Geschäftsführer
    20 Rue Des Cendres
    Rueil Malmaison
    92500
    France
    FranceFrench124860440001
    RAPP, Richard
    16 Spoonbill
    FOREIGN Irvine
    California 92714
    Usa
    Geschäftsführer
    16 Spoonbill
    FOREIGN Irvine
    California 92714
    Usa
    American30404320001
    SCOREY, Michael George
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    Geschäftsführer
    18 Alexander Place
    SW7 2SF London
    United KingdomBritish1749220001
    TAYLOR, Kevin Lee
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish111440290001
    TOBITT, Nigel Derek Charles
    47 West Borough
    BH21 1LX Wimborne
    Dorset
    Geschäftsführer
    47 West Borough
    BH21 1LX Wimborne
    Dorset
    British39085490001
    WESTON, Paul
    Oak House
    Blymhill Common
    TF11 8JP Shifnal
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Oak House
    Blymhill Common
    TF11 8JP Shifnal
    Shropshire
    UkBritish61904620001

    Hat MEDIGAS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating security document
    Erstellt am 19. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture executed in respect of a £45,500,000 senior credit agreement (as defined)
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 11. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC,as Agent and Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries(As Defined) on the Terms and Conditions Set Out in the Intercreditor Deed (as Defined)
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture executed in respect of a £10,000,000 mezzanine credit agreement (as defined)
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 11. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bartclays Bank PLC,as Agent and Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries(As Defined) on the Terms and Conditions Set Out in the Intercreditor Deed (as Defined)
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 10. Okt. 1991
    Geliefert am 17. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a charge dated 10/1/89.
    Kurze Angaben
    All goodwill and uncalled capital, all patents, patent applications, inventions trade marks etc see form 395 ref. M278C for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Jan. 1989
    Geliefert am 20. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 23. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Okt. 1985
    Geliefert am 22. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    Letter of set off
    Erstellt am 27. Feb. 1985
    Geliefert am 04. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums standing to the credit of any present/future account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1985Registrierung einer Belastung

    Hat MEDIGAS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Dez. 2014Beginn der Liquidation
    27. Jan. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0