TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTUSSAUDS HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01147673
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    • Andere Vergnügungs- und Erholungsaktivitäten n.a. (93290) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LONDON DUNGEON LIMITED26. Nov. 197326. Nov. 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2015

    • Kapital: GBP 5.731
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Fraser Stewart Montgomery als Geschäftsführer am 12. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Donald Glenn Earlam als Geschäftsführer am 12. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Fiona Jane Rose als Direktor am 12. Mai 2015

    2 SeitenAP01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed london dungeon LIMITED\certificate issued on 13/04/15
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 25. März 2015

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 15. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 57,310
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 57,310
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2012

    11 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facilies agreement 24/06/2013
    RES13

    Eintragung der Belastung 011476730007

    79 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2010

    11 SeitenAA

    legacy

    25 SeitenMG01

    Ernennung von Colin Armstrong als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Sekretär
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    British172030620001
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritish172030620001
    ROSE, Fiona Jane
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    EnglandBritish93616410002
    CARR, Andrew Christopher
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    Sekretär
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    British65490970002
    CORBEN, Darcy
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Sekretär
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    British111442510002
    DARBY, Barry James Arthur
    240 Bromham Road
    MK40 4AA Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    240 Bromham Road
    MK40 4AA Bedford
    Bedfordshire
    British15988090001
    DOBSON, Laura Jane
    18 Berkeley Mews
    Thames Street
    TW16 5QF Lower Sunbury
    Middlesex
    Sekretär
    18 Berkeley Mews
    Thames Street
    TW16 5QF Lower Sunbury
    Middlesex
    British73308490001
    MORAN, Derek Joseph
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    Sekretär
    Dorrien Lodge March Road
    KT13 8XA Weybridge
    Surrey
    Canadian5332280002
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Sekretär
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British63240980001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritish65490970003
    DARBY, Barry James Arthur
    240 Bromham Road
    MK40 4AA Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    240 Bromham Road
    MK40 4AA Bedford
    Bedfordshire
    British15988090001
    DURE-SMITH, Elisabeth Christine
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Dutch113941400001
    EARLAM, Donald Glenn
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    United KingdomBritish136758950001
    FISHER, Mark Peter Edmund
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    United KingdomBritish164080030001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Geschäftsführer
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    IRENS, Nicholas James
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    British65447080002
    MONTGOMERY, Fraser
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Great Britain
    EnglandBritish200952930001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritish63240980001
    VARNEY, Nick John
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    EnglandBritish246351270001

    Hat TUSSAUDS HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Juni 2013
    Geliefert am 03. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Senior Creditors (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A second confirmatory security agreement
    Erstellt am 24. Mai 2011
    Geliefert am 31. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank Ag London Branch
    Transaktionen
    • 31. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A confirmatory security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 2010
    Geliefert am 20. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank, Ag London Branch
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Juni 2008
    Geliefert am 11. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured italian creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A security agreement
    Erstellt am 21. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured row creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of accession
    Erstellt am 24. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag London Branch as Security Agent
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & trust debenture.
    Erstellt am 06. März 1991
    Geliefert am 20. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents and the security documents (as defined).
    Kurze Angaben
    Various properties as defined in from 395 ref: M100.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC(For Itself National Westmister Nank PLC and the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transaktionen
    • 20. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0