BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01148196 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Glendevon House Hawthorn Park Coal Road LS14 1PQ Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BARRON CONTROL PANELS LIMITED | 28. Nov. 1973 | 28. Nov. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Yardley Court 11/12 Frederick Rd Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1JD am 28. Mai 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 10 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROXSON, Neil Michael | Geschäftsführer | 15 Kyle Way Nether Poppleton YO26 6RH York | Uk | British | 96469690002 | |||||
| LASCHKAR, Henri-Paul | Geschäftsführer | 23 Hyde Park Place W2 2LP London Flat 2 | Uk | French | 139160640001 | |||||
| CARTLIDGE, Gary John | Sekretär | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | British | 11920020001 | ||||||
| EVETTS, John Graham | Sekretär | 72 Sycamore Avenue RM14 2HS Upminster Essex | Pollish/British | 56188860003 | ||||||
| JAMES, Simon Michael | Sekretär | 37 Brand Hill Drive Crofton WF4 1PF Wakefield Yorkshire | British | 111338120001 | ||||||
| JENKINSON, Roger Anthony | Sekretär | Pollensa 3 Fledburgh Drive New Hall B76 1ED Sutton Coldfield West Midlands | British | 985860002 | ||||||
| SABIN, Douglas Harold | Sekretär | 8 Radcliffe Drive B62 8PJ Halesowen West Midlands | British | 52697160001 | ||||||
| TALLIS, Aleksandra Jadwiga | Sekretär | 6 St Chads Grove LS6 3PN Leeds West Yorkshire | Polish | 34638000004 | ||||||
| TRIGGER, Roy | Sekretär | 48 Bartel Close Leverstock Green HP3 8LY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 11920010002 | ||||||
| CARTLIDGE, Alison Mai | Geschäftsführer | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 12921200001 | |||||
| CARTLIDGE, Gary John | Geschäftsführer | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 11920020001 | |||||
| CARTLIDGE, Gary John | Geschäftsführer | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 11920020001 | |||||
| FORRESTER, Andrew John | Geschäftsführer | The Shieling 70 Tiddington Road CV37 7BA Stratford Upon Avon | United Kingdom | British | 97001960001 | |||||
| LEE, Michael William George | Geschäftsführer | Forleas Hotley Bottom Lane Prestwood HP16 9PL Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 14069700001 | |||||
| LEE, Michael William George | Geschäftsführer | Forleas Hotley Bottom Lane Prestwood HP16 9PL Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 14069700001 | |||||
| MC NAB, William Douglas | Geschäftsführer | 57 Pelican Road Pamber Heath RG26 6EL Basingstoke Hampshire | British | 23845420001 | ||||||
| MC NAB, William Douglas | Geschäftsführer | 57 Pelican Road Pamber Heath RG26 6EL Basingstoke Hampshire | British | 23845420001 | ||||||
| MUGFORD, Mary Elizabeth | Geschäftsführer | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | Great Britain | British | 12921220001 | |||||
| MUGFORD, Stanley Sidney George | Geschäftsführer | Hendre Loudwater Lane WD3 4AN Rickmansworth Hertfordshire | British | 12921230001 | ||||||
| MULLEN, Kenneth John | Geschäftsführer | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | United Kingdom | Scottish | 146642810001 | |||||
| NICHOLS, Matt Ward, Mr. | Geschäftsführer | 18 Sweetpool Lane Hagley DY8 2XH Stourbridge West Midlands | England | British | 177829370001 | |||||
| PASSMAN, Jonathan Richard | Geschäftsführer | Stonefield Close Wigston Park Walsgrave CV2 2PZ Coventry 6 | British | 122460330002 | ||||||
| WISHART, John Oliver | Geschäftsführer | 14 Edwards Avenue South Ruislip HA4 6UZ Ruislip Middlesex | British | 12921240001 |
Hat BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 19. März 1998 Geliefert am 21. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. März 1987 Geliefert am 17. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BARRON AUTOMATION SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0