GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED

GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01148888
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    • Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Aug. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis25. März 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung08. Apr. 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis25. März 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2023

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von David Bernard-Cuisinier als Geschäftsführer am 05. Apr. 2023

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2022

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2021

    23 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2020

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Stephane Bernard Gigou als Direktor am 18. März 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Marie Helene Simone Feuillet als Geschäftsführer am 18. März 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Francois Marie Feuillet als Geschäftsführer am 18. März 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2019

    21 SeitenAA

    Ernennung von Mr David Bernard-Cuisinier als Direktor am 19. Juli 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jerome Durand als Geschäftsführer am 16. Juli 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018

    21 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2017

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2016

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. März 2015

    Kapitalaufstellung am 30. März 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FREICHE, Michel
    Les Marchis
    Chanos Curson
    26600
    France
    Sekretär
    Les Marchis
    Chanos Curson
    26600
    France
    FrenchCfo81010610001
    FREICHE, Michel
    Rue Petit
    Paris
    100
    75019
    France
    Geschäftsführer
    Rue Petit
    Paris
    100
    75019
    France
    FranceFrenchManaging Director147770660001
    GIGOU, Stephane Bernard
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Geschäftsführer
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    FranceFrenchChair Person281280650001
    OWEN, Christine Edith
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    British7658750001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    BritishCertified Accountant21912090001
    YATES, John Martyn
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    BritishSolicitor7608780001
    BERNARD-CUISINIER, David
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    Geschäftsführer
    Broadway
    Hyde
    SK14 4QF
    FranceFrenchCompany Director260965170001
    BLUTH, Thomas
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    Geschäftsführer
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    AmericanAttorney70476630001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector117111790001
    DAVIES, Carol Ann
    40 Meadows View
    Marford
    LL12 8LS Wrexham
    Clwyd
    Geschäftsführer
    40 Meadows View
    Marford
    LL12 8LS Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director7658770003
    DURAND, Jerome
    Chemin Du Brian
    Chavannes
    Chemin Du Brian
    26260
    France
    Geschäftsführer
    Chemin Du Brian
    Chavannes
    Chemin Du Brian
    26260
    France
    FranceFrenchDirector134423070001
    FAWCETT, Michael Alan
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant38913590002
    FEUILLET, Francois Marie
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    Geschäftsführer
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    FranceFrenchDirector68087480002
    FEUILLET, Marie Helene Simone
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    Geschäftsführer
    Rue De Lubeck
    FOREIGN Paris
    38
    75116
    France
    FranceFrenchDirector81010520002
    FOX, Patrick Adam Charles
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    Geschäftsführer
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    BritishCompany Director34607130001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director61236690001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector61236690001
    HERSH, Robert
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    Geschäftsführer
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    United StatesExecutive72215110001
    MARBLE, Stephen Gerald
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    Geschäftsführer
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    AmericanCfo86928580001
    OWEN, Christine Edith
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Robins Close
    Bramhall
    SK7 2PF Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Secretary7658750001
    OWEN, Christopher John
    197 Grove Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7NG Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    197 Grove Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7NG Cheadle
    Cheshire
    BritishCompany Director7658760002
    PRICE, William Anthony
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director45498850001
    RAPPAPORT, Dean
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    Geschäftsführer
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    AmericanExecutive71410030001
    RODNEY, Gary
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    Geschäftsführer
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    AmericanDirector102721900001
    SASNETT, David Warren
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    Geschäftsführer
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    AmericanAccountant76805900001
    SKILLEN, Robert Lynn
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    Geschäftsführer
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    BritishCfo80493540001
    TOROSSIAN, Henri
    Costebelle Ii
    Saint Peray
    07130
    France
    Geschäftsführer
    Costebelle Ii
    Saint Peray
    07130
    France
    FrenchDirector82005290001
    VARAKIAN, Robert
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    Geschäftsführer
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    AmericanDirector102721240001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCertified Accountant21912090001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Francois Marie Feuillet
    100 Rue Petit
    75165
    Paris
    Trigan
    Cedex 19
    France
    06. Apr. 2016
    100 Rue Petit
    75165
    Paris
    Trigan
    Cedex 19
    France
    Nein
    Nationalität: French
    Staatsangehörigkeit: France
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Trigano Sa
    Rue Petit
    75165
    Paris
    100
    Cedex 19
    France
    06. Apr. 2016
    Rue Petit
    75165
    Paris
    100
    Cedex 19
    France
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandFrance
    RechtsgrundlageFrench Law
    RegistrierungsortFrance
    Registrierungsnummer722049459
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Apr. 2005
    Geliefert am 25. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land on the west side of broadway hyde t/no GM12514. By way of fixed charge all other property, all computer vehicles equipment, the benefit of all contracts, all charges securities, the security accounts, the intellectual property and all the goodwill and uncalled capital. Assigns the relevant contracts, the insurances, the security accounts and all receivables. Floating charge all assets and undertaking and heritable property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture (supplementing and amending a guarantee and debenture dated 23 december 2003)
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 04. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the blocked accounts, book debts,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida) as Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida) (the Agent) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Loan and security agreement
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any or all of borrowers to agent or any lender and/or any of their affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral being all accounts all general intangibles including without limitation all intellectual property all goods all real property and fixtures all chattel paper all instruments all documents and all deposit accounts * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida), in Its Capacity as Agent for Lenders (the Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 2002
    Geliefert am 14. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as marlborough works marlborough road accrington england BB5 5BE title number LA858360. Freehold property known as beza road hunslet leeds england LS10 2BR title number WYK569370. The leasehold property known as broadway broadway industrial estate hyde greater manchester SK14 5BE title number GM12514. For further details of properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks
    Transaktionen
    • 14. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Aug. 2000
    Geliefert am 01. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under or in connection with the facilities or any document given as security therefor by any such obligor on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks (As Defined) ("Administrative Agent")
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1998
    Geliefert am 12. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1996
    Geliefert am 22. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1996
    Geliefert am 20. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 19. Dez. 1995
    Geliefert am 20. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Sept. 1995
    Geliefert am 30. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Griffin Factors Limited
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed equitable charge
    Erstellt am 28. Sept. 1995
    Geliefert am 30. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts invoice debts accounts,notes bills,acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Griffin Factors Limited
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 27. Mai 1988
    Geliefert am 08. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all the book and other debts floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Mai 1985
    Geliefert am 10. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and a legal mortgage over unit 4, pottinger street, ashton-u-lyne. Tameside OL7 0PS greater manchester title no la 265114 and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 27. Nov. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 30. Nov. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge or all book & other debts with a floating charge on undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. (Please see-doc M21).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1980
    Geliefert am 28. Aug. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000
    Kurze Angaben
    Unit 4, pottinger street, ashton-under-lyne, greater manchester. Title no:- LA265114.
    Berechtigte Personen
    • Sun Life Assurance Society Limited.
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0