GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01148888 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Broadway Hyde SK14 4QF |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Aug. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Mai 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. März 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 08. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. März 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2023 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Bernard-Cuisinier als Geschäftsführer am 05. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2022 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2021 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephane Bernard Gigou als Direktor am 18. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marie Helene Simone Feuillet als Geschäftsführer am 18. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francois Marie Feuillet als Geschäftsführer am 18. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David Bernard-Cuisinier als Direktor am 19. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jerome Durand als Geschäftsführer am 16. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. März 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREICHE, Michel | Sekretär | Les Marchis Chanos Curson 26600 France | French | Cfo | 81010610001 | |||||
FREICHE, Michel | Geschäftsführer | Rue Petit Paris 100 75019 France | France | French | Managing Director | 147770660001 | ||||
GIGOU, Stephane Bernard | Geschäftsführer | Broadway Hyde SK14 4QF | France | French | Chair Person | 281280650001 | ||||
OWEN, Christine Edith | Sekretär | 12 Robins Close Bramhall SK7 2PF Stockport Cheshire | British | 7658750001 | ||||||
WELHAM, Anthony Frederick | Sekretär | 82 West End Lane Horsforth LS18 5EP Leeds West Yorkshire | British | Certified Accountant | 21912090001 | |||||
YATES, John Martyn | Sekretär | 5 Melia Close BB4 6RQ Rossendale Lancashire | British | Solicitor | 7608780001 | |||||
BERNARD-CUISINIER, David | Geschäftsführer | Broadway Hyde SK14 4QF | France | French | Company Director | 260965170001 | ||||
BLUTH, Thomas | Geschäftsführer | 289 Landines Blvd Weston 33327 Usa | American | Attorney | 70476630001 | |||||
DAVIDSON, Bruce Wood Hardy | Geschäftsführer | Moor Close St Johns Park Menston Ilkley LS29 6ES Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 117111790001 | ||||
DAVIES, Carol Ann | Geschäftsführer | 40 Meadows View Marford LL12 8LS Wrexham Clwyd | British | Company Director | 7658770003 | |||||
DURAND, Jerome | Geschäftsführer | Chemin Du Brian Chavannes Chemin Du Brian 26260 France | France | French | Director | 134423070001 | ||||
FAWCETT, Michael Alan | Geschäftsführer | 94 Mottram Old Road SK15 2TE Stalybridge Cheshire | British | Accountant | 38913590002 | |||||
FEUILLET, Francois Marie | Geschäftsführer | Rue De Lubeck FOREIGN Paris 38 75116 France | France | French | Director | 68087480002 | ||||
FEUILLET, Marie Helene Simone | Geschäftsführer | Rue De Lubeck FOREIGN Paris 38 75116 France | France | French | Director | 81010520002 | ||||
FOX, Patrick Adam Charles | Geschäftsführer | 30 Dorville Crescent W6 0HJ London | British | Company Director | 34607130001 | |||||
HALL, John Maddison | Geschäftsführer | The Granary Briery Hall Farm Chevet Lane WF2 6PT Wakefield West Yorkshire | England | British | Company Director | 61236690001 | ||||
HALL, John Maddison | Geschäftsführer | The Granary Briery Hall Farm Chevet Lane WF2 6PT Wakefield West Yorkshire | England | British | Director | 61236690001 | ||||
HERSH, Robert | Geschäftsführer | 6700 Sw 88 Terrace Miami FOREIGN Florida 33156 United States | United States | Executive | 72215110001 | |||||
MARBLE, Stephen Gerald | Geschäftsführer | 10430 Sw 20 Street Davie Florida Fl33324 Usa | American | Cfo | 86928580001 | |||||
OWEN, Christine Edith | Geschäftsführer | 12 Robins Close Bramhall SK7 2PF Stockport Cheshire | British | Company Secretary | 7658750001 | |||||
OWEN, Christopher John | Geschäftsführer | 197 Grove Lane Cheadle Hulme SK8 7NG Cheadle Cheshire | British | Company Director | 7658760002 | |||||
PRICE, William Anthony | Geschäftsführer | 34 Lea Drive Shepley HD8 8HA Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 45498850001 | ||||
RAPPAPORT, Dean | Geschäftsführer | 11988 Classic Drive Coral Springs Florida 33071 Usa | American | Executive | 71410030001 | |||||
RODNEY, Gary | Geschäftsführer | 3101 Pierson Drive FLORIDA Delray Beach 33483 Usa | American | Director | 102721900001 | |||||
SASNETT, David Warren | Geschäftsführer | 16254 S.W.67 Court Fort Lauderdale Florida 33331 Usa | American | Accountant | 76805900001 | |||||
SKILLEN, Robert Lynn | Geschäftsführer | Apt 510 7345 Fairway Drive FOREIGN Miami Lakes Florida 33014 United States | British | Cfo | 80493540001 | |||||
TOROSSIAN, Henri | Geschäftsführer | Costebelle Ii Saint Peray 07130 France | French | Director | 82005290001 | |||||
VARAKIAN, Robert | Geschäftsführer | 17555 Collins Avenue Apt 1703 FLORIDA Sunny Isles Beach 33160 America | American | Director | 102721240001 | |||||
WELHAM, Anthony Frederick | Geschäftsführer | 82 West End Lane Horsforth LS18 5EP Leeds West Yorkshire | England | British | Certified Accountant | 21912090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Francois Marie Feuillet | 06. Apr. 2016 | 100 Rue Petit 75165 Paris Trigan Cedex 19 France | Nein | ||||||||||
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: France | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Trigano Sa | 06. Apr. 2016 | Rue Petit 75165 Paris 100 Cedex 19 France | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GROVE PRODUCTS (CARAVAN ACCESSORIES) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 18. Apr. 2005 Geliefert am 25. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land on the west side of broadway hyde t/no GM12514. By way of fixed charge all other property, all computer vehicles equipment, the benefit of all contracts, all charges securities, the security accounts, the intellectual property and all the goodwill and uncalled capital. Assigns the relevant contracts, the insurances, the security accounts and all receivables. Floating charge all assets and undertaking and heritable property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture (supplementing and amending a guarantee and debenture dated 23 december 2003) | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 04. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the blocked accounts, book debts,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Dez. 2003 Geliefert am 24. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Loan and security agreement | Erstellt am 23. Dez. 2003 Geliefert am 09. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any or all of borrowers to agent or any lender and/or any of their affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The collateral being all accounts all general intangibles including without limitation all intellectual property all goods all real property and fixtures all chattel paper all instruments all documents and all deposit accounts * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Mai 2002 Geliefert am 14. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The leasehold property known as marlborough works marlborough road accrington england BB5 5BE title number LA858360. Freehold property known as beza road hunslet leeds england LS10 2BR title number WYK569370. The leasehold property known as broadway broadway industrial estate hyde greater manchester SK14 5BE title number GM12514. For further details of properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 18. Aug. 2000 Geliefert am 01. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under or in connection with the facilities or any document given as security therefor by any such obligor on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Nov. 1998 Geliefert am 12. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 15. Nov. 1996 Geliefert am 22. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Nov. 1996 Geliefert am 20. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 19. Dez. 1995 Geliefert am 20. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 28. Sept. 1995 Geliefert am 30. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed equitable charge | Erstellt am 28. Sept. 1995 Geliefert am 30. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts invoice debts accounts,notes bills,acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Mai 1988 Geliefert am 08. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all the book and other debts floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Mai 1985 Geliefert am 10. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and a legal mortgage over unit 4, pottinger street, ashton-u-lyne. Tameside OL7 0PS greater manchester title no la 265114 and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Nov. 1982 Geliefert am 03. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge or all book & other debts with a floating charge on undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. (Please see-doc M21). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 1980 Geliefert am 28. Aug. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000 | |
Kurze Angaben Unit 4, pottinger street, ashton-under-lyne, greater manchester. Title no:- LA265114. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0