BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01150202 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Park Place St James's SW1A 1LP London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rachel Elizabeth Robertson als Geschäftsführer am 09. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Sept. 2017 bis 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Notification of London & Birmingham Hotels Limited as a person with significant control on 28. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Metropole Hotels (Holdings) Limited as a person with significant control on 28. Sept. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Norman Alan Smith als Geschäftsführer am 24. Okt. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Oded Wojakovski als Sekretär am 02. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Arthur Matyas als Geschäftsführer am 02. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Oded Wojakovski als Geschäftsführer am 02. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Norman Alan Smith am 01. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Rachel Elizabeth Robertson am 01. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Arthur Matyas am 01. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2014 bis 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tricor Suite 7Th Floor 52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOTH, James William | Sekretär | 27 Avenue Road CV37 6UN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 58028160001 | ||||||
| MACKAY, William Donald | Sekretär | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| WILSON, Brian | Sekretär | Tudor Cottage 70 High Street, Eaton Bray LU6 2DP Dunstable | British | 125151140001 | ||||||
| WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr | Sekretär | 3 Park Place St. James`S SW1A 1LP London | British | 114629300001 | ||||||
| LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 60530770001 | |||||||
| BOLLAND, Martin Keith | Geschäftsführer | 11 Fairways 1240 Warwick Road Copt Heath B93 9LL Solihull Warwickshire | British | 4848800001 | ||||||
| BOOTH, James William | Geschäftsführer | 27 Avenue Road CV37 6UN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 58028160001 | ||||||
| BOWCOCK, Philip Hedley | Geschäftsführer | East Barn Glory Hill Farm HP9 1XE Beaconsfield Bucks | British | 111188430001 | ||||||
| BRADLEY, Adrian Paul | Geschäftsführer | The Spinney Misbourne Avenue SL9 0PF Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Geschäftsführer | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||
| DUNLOP, Robert Fergus | Geschäftsführer | 42 Woodsford Square W14 8DP London | British | 4848780001 | ||||||
| FRIEDMAN, Howard | Geschäftsführer | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | Usa | 106914780001 | ||||||
| HUMPHREYS, Stephen | Geschäftsführer | 1 Victoria Yard Fairclough Street E1 1PP London | British | 71438830002 | ||||||
| JAMES, Paul Frederick | Geschäftsführer | 53 Lonsdale Drive Oakwood EN2 7LR Enfield | British | 48791500001 | ||||||
| LEE, Jonathan Francis | Geschäftsführer | Bucket Lock Cottage Yarningale Lane CV35 8HW Yarningale Common Warwickshire | England | British | 125160200001 | |||||
| MACKAY, William Donald | Geschäftsführer | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MATYAS, Arthur | Geschäftsführer | 3 Park Place St James's SW1A 1LP London | United Kingdom | British, | 36810610001 | |||||
| MICHELS, David Michael Charles | Geschäftsführer | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||
| ROBERTSON, Ian | Geschäftsführer | 5 Boswall Road EH5 3RH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 106197810002 | |||||
| ROBERTSON, Rachel Elizabeth | Geschäftsführer | 3 Park Place St James's SW1A 1LP London | England | British | 96527400001 | |||||
| ROWLAND, Roland Walter | Geschäftsführer | Hedsor Wharf SL8 5JN Bourne End Buckinghamshire | British | 34590730001 | ||||||
| SMITH, Norman Alan | Geschäftsführer | 3 Park Place St James's SW1A 1LP London | Scotland | British | 156114890001 | |||||
| SPICER, Paul George Bullen | Geschäftsführer | 22 Ovington Gardens SW3 London | British | 4848790001 | ||||||
| TARSH, Philip Maurice | Geschäftsführer | 26 The Ridgeway KT22 9AZ Fetcham Surrey | British | 33106400001 | ||||||
| THOMSON, Jonathan David | Geschäftsführer | 79 Hamlet Gardens Hammersmith W6 0SX London | British | 117323980001 | ||||||
| WAY, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Princess Diana Drive AL4 0DY St. Albans 15 Hertfordshire | United Kingdom | British | 143355690001 | |||||
| WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr | Geschäftsführer | 3 Park Place St. James`S SW1A 1LP London | England | British | 114629300001 | |||||
| LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 62360460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London & Birmingham Hotels Limited | 28. Sept. 2017 | Park Place St James' SW1A 1LP London 3 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Metropole Hotels (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Park Place St James's SW1A 1LP London 3 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 2006 Geliefert am 07. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tonstate metropole hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a land lying to the west of pendigo way bickenhill t/no WM644010 and all that l/h land k/a land on the west side of pendigo way bickenhill t/no 422365 all that l/h land k/a part land lying to the west of pendigo way bickenhill t/no WM496382 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Nov. 2006 Geliefert am 05. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental mortgage. | Erstellt am 24. Sept. 1984 Geliefert am 25. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from A.V.P. industries to the chargee under the terms of the principal agreement as amended by the second supplemental agreement. | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property 7 chelmsley lane, masten green, and 76 shirley rd, acocksgreen leasehold land t/n WM144434 goodwill, book debts both present and fixtures for further details see doc 31. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental agreement. | Erstellt am 07. Aug. 1981 Geliefert am 11. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from A.V.P. industries limited to the chargee not exceeding £4,000,000 supplemental to the loan agreement dated 15.7.80. | |
Kurze Angaben L/H and comprised in title no wm 144434. with all buildings & fixtures all f/h & l/h property of the company with all buildings, fixtures, goodwill, uncalled capital, uncalled capital, bookdebts (see doc for full details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Juli 1980 Geliefert am 22. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H metropole and warwick hotels, national exhibition centre, bickenhill. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including, goodwill, book-debts, uncalled capital. Stock-in-trade, work-in-progress, prepayments. Except the properties known as 7, chennsley lane marston green, & 76 shirley road, acock & green. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0