HARWORTH POWER LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HARWORTH POWER LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01156905 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HARWORTH POWER LIMITED?
- Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
Wo befindet sich HARWORTH POWER LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HARWORTH POWER LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
FILTRACITE LIMITED | 15. Jan. 1974 | 15. Jan. 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARWORTH POWER LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HARWORTH POWER LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 23 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Tod eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ09 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2020 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2019 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2018 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2017 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 19. Apr. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2016 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 9 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2015 | 18 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2014 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harworth Park Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* am 18. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Martin Terence Alan Purvis als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harworth Secretariat Services Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Uk Coal Secretariat Services Limited am 17. Apr. 2013 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HARWORTH POWER LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | 177796090001 | |||||||||||
HUTCHINSON, Stephen John | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | United Kingdom | British | Finance Director | 174502100001 | ||||||||
REED, Colin Frederick | Geschäftsführer | Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire England | England | British | None | 174641750001 | ||||||||
BELLAMY, Valerie | Sekretär | Granary Cottage Clayworth DN22 9AD Retford Notts | British | Accountant | 33796010001 | |||||||||
COLE, Richard Andrew | Sekretär | Lodge Farm Eakring Road, Wellow NG22 0EG Newark Nottinghamshire | British | 58361870002 | ||||||||||
GARNESS, Melvin | Sekretär | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | British | Company Director | 18761260001 | |||||||||
RHODES, Jeremy | Sekretär | Harworth Park Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster South Yorkshire | British | 169990670001 | ||||||||||
SHAW, Mary Teresa | Sekretär | 5 Lanark Drive S64 0QY Mexborough South Yorkshire | British | 6780940001 | ||||||||||
HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire United Kingdom |
| 172322000002 | ||||||||||
BREHENY, Thomas | Geschäftsführer | Hye Bern Clyro Place Sutton Cum Lound DN22 8PE Retford | United Kingdom | British | Company Director | 126526650001 | ||||||||
BROCKSOM, David Graham | Geschäftsführer | 7 York Road HG1 2QA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 96416100003 | ||||||||
BUDGE, Richard John | Geschäftsführer | Wiseton Hall Wiseton DN10 5AE Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 27948060002 | ||||||||
COLE, Richard Andrew | Geschäftsführer | Eakring Road Wellow NG22 0EG Newark Lodge Farm | England | British | Company Secretary | 58361870002 | ||||||||
GARNESS, Melvin | Geschäftsführer | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 18761260001 | ||||||||
HAGUE, Jeremy Richard | Geschäftsführer | Park Crescent DN22 6UF Retford 5 Nottinghamshire | England | British | Accountant | 115747040001 | ||||||||
JARRETT, George William | Geschäftsführer | Wenvoe 51 Woodhill Road Collingham NG23 7NR Newark Nottinghamshire | British | Company Director | 30751750001 | |||||||||
LANDON, David | Geschäftsführer | Thorpe House Headon DN22 0RD Retford Nottinghamshire | British | Assistant Group Director | 39068820003 | |||||||||
LLOYD, Jonathan Simon | Geschäftsführer | Orchard House Marton Cum Grafton YO51 9QY York | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 95211330002 | ||||||||
LONGDEN, John Charles Henry | Geschäftsführer | Stonebank Potter Lane Wellow NG22 0EB Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | Group Director | 15825610001 | ||||||||
MARSHALL, Dennis | Geschäftsführer | Avebury House 7 Dunniwood Reach Bessacarr DN4 7AS Doncaster South Yorks | British | Accountant | 6780950001 | |||||||||
MAWE, Christopher | Geschäftsführer | 5 Back Lane Whixley YO26 8BG York North Yorkshire | British | Finance Director | 99084660001 | |||||||||
MCPHIE, Gordon Allister | Geschäftsführer | Wigley Green Farmhouse S42 7JJ Old Brampton Derbyshire | British | Company Director | 35904020001 | |||||||||
MICHAELSON, Richard Owen | Geschäftsführer | Ebford EX3 0PA Exeter Four Winds Devon | England | British | Company Director | 174637950001 | ||||||||
O'BRIEN, Patrick Sampson | Geschäftsführer | The Pantiles Main Street Hayton DN22 9LH Retford Nottinghamshire | British | Company Director | 52186290001 | |||||||||
OLDHAM, David Raymond | Geschäftsführer | 2 Lake Farm Road Rainworth NG21 0ED Mansfield Nottinghamshire | United Kingdom | British | Engineereing Manager | 30622580001 | ||||||||
PARKER, Susan Patricia | Geschäftsführer | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber South Humberside | British | Purchasing Manager | 29758680001 | |||||||||
PARKIN, Stephen John | Geschäftsführer | 87 Sparken Hill S80 3AJ Worksop Nottinghamshire | British | Colliery Manager | 39068910002 | |||||||||
PENNELL, Christopher Hedley | Geschäftsführer | 6 Alms Hill Road S11 9RS Sheffield South Yorkshire | British | Purchasing Manager | 31270970001 | |||||||||
ROBERTS, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire England | United Kingdom | British | None | 174640290001 | ||||||||
ROWELL, William | Geschäftsführer | 6 Bracken Lane DN22 7EU Retford Nottinghamshire | British | Company Director | 35205460002 | |||||||||
SHAW, Mary Teresa | Geschäftsführer | 5 Lanark Drive S64 0QY Mexborough South Yorkshire | British | Accountant | 6780940001 | |||||||||
SPINDLER, Garold Ralph | Geschäftsführer | Manor House Westhaugh Tumbling Hill Carleton WF8 2RP Pontefract | American | Mining Engineer | 101195530002 | |||||||||
WRIGHT, Brian Charles | Geschäftsführer | Oaklands 17 Heath Avenue NG18 3EU Mansfield Nottinghamshire | British | Group Director | 40551720001 |
Hat HARWORTH POWER LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession | Erstellt am 26. Apr. 2012 Geliefert am 03. Mai 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Its credit balances. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 10. Okt. 2008 Geliefert am 17. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,400,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The items listed on the schedule being - kellingley colliery, york chiller unit 1, serial number 24190 D.O.M. 2002; york chiller unit 2, serial number 24195, D.O.M. 2002; hoval farrar limited water separator, serial number 55084, D.O.M. 1991, for details of further goods charged please refer to form 395, together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge over chattels | Erstellt am 03. Jan. 2007 Geliefert am 04. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 ge jenbacher 420 series containerised spark ignition gas engine generators rating - 1415KWE 415V 50HZ 0.8PF fuel - methane/mines gas/natural gas generators are complete units with gas train contral system synchronising breaker cooling water radiators lube oil system exhaust silencer serial numbers engine 1 3318911 engine 2 3398281. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and | Erstellt am 01. März 2006 Geliefert am 14. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. März 2004 Geliefert am 25. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. März 2004 Geliefert am 17. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all moneys standing to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the benefit of all authorisations. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Okt. 1999 Geliefert am 19. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HARWORTH POWER LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0