HARWORTH POWER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHARWORTH POWER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01156905
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HARWORTH POWER LIMITED?

    • Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft

    Wo befindet sich HARWORTH POWER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HARWORTH POWER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FILTRACITE LIMITED15. Jan. 197415. Jan. 1974

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARWORTH POWER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für HARWORTH POWER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    23 SeitenLIQ14

    Tod eines Liquidators

    3 SeitenLIQ09

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2020

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2019

    13 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2018

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2017

    16 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 19. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2016

    11 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2015

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2014

    15 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harworth Park Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* am 18. Juli 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Martin Terence Alan Purvis als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Harworth Secretariat Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Sekretärs für Uk Coal Secretariat Services Limited am 17. Apr. 2013

    1 SeitenCH04

    Jahresrückblick erstellt bis 24. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von HARWORTH POWER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PURVIS, Martin Terence Alan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Sekretär
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    177796090001
    HUTCHINSON, Stephen John
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United KingdomBritishFinance Director174502100001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone174641750001
    BELLAMY, Valerie
    Granary Cottage
    Clayworth
    DN22 9AD Retford
    Notts
    Sekretär
    Granary Cottage
    Clayworth
    DN22 9AD Retford
    Notts
    BritishAccountant33796010001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Sekretär
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Sekretär
    Harworth Park
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    British169990670001
    SHAW, Mary Teresa
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    Sekretär
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    British6780940001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8223049
    172322000002
    BREHENY, Thomas
    Hye Bern Clyro Place
    Sutton Cum Lound
    DN22 8PE Retford
    Geschäftsführer
    Hye Bern Clyro Place
    Sutton Cum Lound
    DN22 8PE Retford
    United KingdomBritishCompany Director126526650001
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Geschäftsführer
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritishCompany Secretary58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director18761260001
    HAGUE, Jeremy Richard
    Park Crescent
    DN22 6UF Retford
    5
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Park Crescent
    DN22 6UF Retford
    5
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant115747040001
    JARRETT, George William
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director30751750001
    LANDON, David
    Thorpe House
    Headon
    DN22 0RD Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Thorpe House
    Headon
    DN22 0RD Retford
    Nottinghamshire
    BritishAssistant Group Director39068820003
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Geschäftsführer
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritishChartered Surveyor95211330002
    LONGDEN, John Charles Henry
    Stonebank Potter Lane
    Wellow
    NG22 0EB Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Stonebank Potter Lane
    Wellow
    NG22 0EB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Director15825610001
    MARSHALL, Dennis
    Avebury House 7 Dunniwood Reach
    Bessacarr
    DN4 7AS Doncaster
    South Yorks
    Geschäftsführer
    Avebury House 7 Dunniwood Reach
    Bessacarr
    DN4 7AS Doncaster
    South Yorks
    BritishAccountant6780950001
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    BritishFinance Director99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    BritishCompany Director35904020001
    MICHAELSON, Richard Owen
    Ebford
    EX3 0PA Exeter
    Four Winds
    Devon
    Geschäftsführer
    Ebford
    EX3 0PA Exeter
    Four Winds
    Devon
    EnglandBritishCompany Director174637950001
    O'BRIEN, Patrick Sampson
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director52186290001
    OLDHAM, David Raymond
    2 Lake Farm Road
    Rainworth
    NG21 0ED Mansfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Lake Farm Road
    Rainworth
    NG21 0ED Mansfield
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishEngineereing Manager30622580001
    PARKER, Susan Patricia
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    South Humberside
    Geschäftsführer
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    South Humberside
    BritishPurchasing Manager29758680001
    PARKIN, Stephen John
    87 Sparken Hill
    S80 3AJ Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    87 Sparken Hill
    S80 3AJ Worksop
    Nottinghamshire
    BritishColliery Manager39068910002
    PENNELL, Christopher Hedley
    6 Alms Hill Road
    S11 9RS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Alms Hill Road
    S11 9RS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishPurchasing Manager31270970001
    ROBERTS, Nicholas Andrew
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishNone174640290001
    ROWELL, William
    6 Bracken Lane
    DN22 7EU Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    6 Bracken Lane
    DN22 7EU Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director35205460002
    SHAW, Mary Teresa
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    BritishAccountant6780940001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Geschäftsführer
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    AmericanMining Engineer101195530002
    WRIGHT, Brian Charles
    Oaklands
    17 Heath Avenue
    NG18 3EU Mansfield
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Oaklands
    17 Heath Avenue
    NG18 3EU Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishGroup Director40551720001

    Hat HARWORTH POWER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession
    Erstellt am 26. Apr. 2012
    Geliefert am 03. Mai 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its credit balances. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 10. Okt. 2008
    Geliefert am 17. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,400,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The items listed on the schedule being - kellingley colliery, york chiller unit 1, serial number 24190 D.O.M. 2002; york chiller unit 2, serial number 24195, D.O.M. 2002; hoval farrar limited water separator, serial number 55084, D.O.M. 1991, for details of further goods charged please refer to form 395, together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed charge over chattels
    Erstellt am 03. Jan. 2007
    Geliefert am 04. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 ge jenbacher 420 series containerised spark ignition gas engine generators rating - 1415KWE 415V 50HZ 0.8PF fuel - methane/mines gas/natural gas generators are complete units with gas train contral system synchronising breaker cooling water radiators lube oil system exhaust silencer serial numbers engine 1 3318911 engine 2 3398281. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Erstellt am 01. März 2006
    Geliefert am 14. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 2004
    Geliefert am 25. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. März 2004
    Geliefert am 17. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all moneys standing to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the benefit of all authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transaktionen
    • 17. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 19. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent)
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HARWORTH POWER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Dez. 2021Soll aufgelöst werden am
    29. Juli 2013Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0