EPS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EPS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01158387 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EPS GROUP LIMITED?
- Installation von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen (43220) / Bauwesen
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich EPS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EPS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EPS PROJECTS LIMITED | 01. Aug. 2001 | 01. Aug. 2001 |
| EPS GROUP LIMITED | 08. Feb. 2000 | 08. Feb. 2000 |
| R L H GROUP LIMITED | 02. Juni 1982 | 02. Juni 1982 |
| ROGER LAMBERT HEATING LIMITED | 28. Jan. 1974 | 28. Jan. 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EPS GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für EPS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Mai 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanne Claire Baxter als Geschäftsführer am 26. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ruby Mcgregor-Smith als Geschäftsführer am 26. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Griffin als Geschäftsführer am 01. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Reeve als Geschäftsführer am 01. Nov. 2013 | TM01 | |||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für William Robson am 25. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ruby Mcgregor-Smith am 25. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Suzanne Claire Baxter am 25. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Griffin am 28. März 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mitie Company Secretarial Services Limited am 20. Jan. 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 8 Monarch Court the Brooms Emersons Green Bristol BS16 7FH* am 20. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ruby Mcgregor-Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EPS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England |
| 148474450001 | ||||||||||
| RIDLEY, Justin | Geschäftsführer | The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 Monarch Court | United Kingdom | British | 167796840001 | |||||||||
| ROBSON, William | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | Scotland | British | 282530002 | |||||||||
| LAMBERT, Wendy Elizabeth | Sekretär | The Wish Willey Lane CR3 6AR Caterham Surrey | British | 10992480001 | ||||||||||
| RAJENDRA, George Rajkumar | Sekretär | 29 Higher Green KT17 3BB Epsom Surrey | British | 4618730002 | ||||||||||
| STEVENS, Robert | Sekretär | 5 Brockley Park Forest Hill SE23 1PT London | British | 46391640001 | ||||||||||
| ANDERSON, David John | Geschäftsführer | Hall Farm Hall Lane Shenfield CM15 0SH Brentwood Essex | United Kingdom | British | 65141060002 | |||||||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||||||
| COX, Jess Randolph | Geschäftsführer | 288 Millfields Road E5 0AR Clapton London | British | 73891380001 | ||||||||||
| COX, Marcus Edward | Geschäftsführer | Abbotsford Gardens IG8 9HP Woodford Green 84 Essex | United Kingdom | British | 246075070001 | |||||||||
| DYBAL, Adrian Derek Sidney | Geschäftsführer | 19 Orchard Road SM1 2QA Sutton Surrey | British | 125457800001 | ||||||||||
| GEORGE, Steven Ronald | Geschäftsführer | 28 Hycliffe Gardens IG7 5HJ Chigwell Essex | British | 82308060001 | ||||||||||
| GINGER, Lee Brian | Geschäftsführer | Downs View Close Pratts Bottom BR6 7SU Orpington 2 Kent | British | 97505650002 | ||||||||||
| GRIFFIN, Peter | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 77000520001 | |||||||||
| HAYTHORPE, Jeffrey John | Geschäftsführer | Towncourt Crescent Petts Wood BR5 1PJ Orpington 48 Kent | England | British | 139661100001 | |||||||||
| HICKEY, Brian James | Geschäftsführer | Old School House GU28 0JZ Petworth 2 West Sussex | British | 133007920001 | ||||||||||
| HOLMES, Peter James | Geschäftsführer | Meadow View 5a Mill Common PE29 3AU Huntingdon Cambs | England | British | 97375340001 | |||||||||
| HUMBERSTONE, John James Leonard | Geschäftsführer | 28 Silverhurst Drive TN10 3QH Tonbridge Kent | British | 10992500001 | ||||||||||
| JEFFERYS, Gary Stephen | Geschäftsführer | Apperfield Road Biggin Hill TW16 3LX Westerham 77 Kent | British | 38836490003 | ||||||||||
| JOHNSTON, Raymond James | Geschäftsführer | 24 The Ridgeway CR0 4AE Croydon Surrey | British | 125398280001 | ||||||||||
| JONES, Stephen John, Director | Geschäftsführer | 7 Creasey Close RM11 1FE Hornchurch Essex | England | English | 108808790001 | |||||||||
| KELLY, Paul David | Geschäftsführer | West Hill House West Hill RH8 9JD Oxted Flat 4 Surrey | British | 133008030002 | ||||||||||
| LAMBERT, Roger Cedric | Geschäftsführer | The Wish Willey Lane CR3 6AR Caterham Surrey | United Kingdom | British | 10992490001 | |||||||||
| LAMBERT, Wendy Elizabeth | Geschäftsführer | The Wish Willey Lane CR3 6AR Caterham Surrey | United Kingdom | British | 10992480001 | |||||||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 39857280005 | |||||||||
| O'DONNELL, James Michael | Geschäftsführer | 29 Great Park Tower Place CR6 9PW Warlingham Surrey | England | British | 121149570002 | |||||||||
| PEARCE, Dennis Roy | Geschäftsführer | 175 Whitmore Avenue Stifford Clays RM16 2HT Grays Essex | British | 73891340001 | ||||||||||
| RAJENDRA, George Rajkumar | Geschäftsführer | 29 Higher Green KT17 3BB Epsom Surrey | British | 4618730002 | ||||||||||
| READER, Paul David | Geschäftsführer | 8a Torrance Close RM11 1JT Hornchurch Essex | British | 92246340002 | ||||||||||
| REEVE, Simon | Geschäftsführer | 1 Forge Cottages Chilbrook Road KT11 3PD Cobham Surrey | British | 93064280001 | ||||||||||
| STURMER, Matthew Philip | Geschäftsführer | 2 East Lodge Dukes Road RH5 5BS Newdigate Surrey | United Kingdom | English | 125398360001 | |||||||||
| WATSON, Gail | Geschäftsführer | Orchard Cottage Church Lane Capel TN12 6SX Tonbridge Kent | England | British | 125398430001 | |||||||||
| ENVIRONMENTAL PROPERTY SERVICES PLC | Geschäftsführer | Broadwalk House 5 Appold Street EC2A 2HA London | 64155070001 |
Hat EPS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 13. Sept. 2010 Geliefert am 22. Sept. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Rent security deposit of twenty three thousand and one hundred pounds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 31. Mai 2006 Geliefert am 03. Juni 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The interest in the account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1999 Geliefert am 18. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction ,and including interest, discount, commission and other lawful charges | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 1998 Geliefert am 24. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 26. Jan. 1998 Geliefert am 31. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 1A carberry road upper norwood SE19 3RX t/n-SGL551148.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Dez. 1991 Geliefert am 24. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £224,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee including further advances | |
Kurze Angaben 1A carberry road formerly k/a land at the rear of 31 westow street and 17 carberry road,upper norwood,london SE9 see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juli 1991 Geliefert am 24. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a: 31 westow street upper norwood london SE19 t/no sy 144944 goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 15. Sept. 1988 Geliefert am 19. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a or being 31 westow street, upper norwood london SE19 and 17 carberry road upper norwood london SE19 t/n sy 14494 & all buildings & fixtures thereon a goods by way of assignment the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 31. Aug. 1988 Geliefert am 15. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Nov. 1984 Geliefert am 09. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 29 westow street, upper norwood, london borough of croydon sy 50064. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1984 Geliefert am 02. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 33 westow street, upper norwood SE19 london borough of croydon and yard to the rear of 35 westow street upper norwood S.e 19 london borough of croydon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juni 1982 Geliefert am 29. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. März 1981 Geliefert am 08. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 226 addington road selsdon london borough of croydon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0