CARRINGTON WELDGRIP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCARRINGTON WELDGRIP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01163702
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HALL EXPORT LIMITED16. Juli 199616. Juli 1996
    C.B.A. (METALS) LIMITED20. März 197420. März 1974

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 17. Dez. 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 03. Juni 2010

    • Kapital: GBP 4,050,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Stuart Morriss am 08. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lloyd Kynaston am 08. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Michael Hayhurst am 08. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von CARRINGTON WELDGRIP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAYHURST, Michael
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    BritishChartered Accountant15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector10529040001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishDirector11643310001
    CRIBB, Nicholas Stephen
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    British100811140001
    DAVIES, John Graeme
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary72253030004
    DOWSETT, Roy
    2 Valley View
    Southborough
    TN4 0SY Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    2 Valley View
    Southborough
    TN4 0SY Tunbridge Wells
    Kent
    British28096930001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    BOWLES, Robin Keith
    Oranmore Cottage Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3QZ Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Oranmore Cottage Copthorne Bank
    Copthorne
    RH10 3QZ Crawley
    West Sussex
    BritishCompany Director49039050001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector72559760001
    DOWSETT, Roy
    2 Valley View
    Southborough
    TN4 0SY Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Valley View
    Southborough
    TN4 0SY Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director28096930001
    HALL, Richard Nicholas Congreve
    Hales Hall
    Hales
    TF9 2PP Market Drayton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Hales Hall
    Hales
    TF9 2PP Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director9819260001
    HINKINS, Brian Edward Walter
    38 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    38 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director52146460001
    HUGHES, Mark Leonard William
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director51202520001
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    BritishDirector131639570001
    KEEN, Peter Winston
    St Anthony Stag Lane
    Chorleywood
    WD3 5HE Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    St Anthony Stag Lane
    Chorleywood
    WD3 5HE Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director28096950001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector40953790002
    ROWLEY, Peter
    Briar Lodge
    The Glen Homer
    TF13 6NE Much Wenlock
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Briar Lodge
    The Glen Homer
    TF13 6NE Much Wenlock
    Shropshire
    BritishDirector49040110002
    SMITH, Alastair Moray
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director9819210001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector1600540001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary36008490001

    Hat CARRINGTON WELDGRIP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A hong kong law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A singapore law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture to target group debenture
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due or to become due from each charging entity to the chargee under or pursuant to the debenture (as amended)
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property (other than the heritable property in scotland) owned by the company or in which the company has an interest at the date of the charge all its other assets and undertakings (and all rights in respect thereof). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture) from Time to Time
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite (singapore law governed) guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite (hong kong law governed) guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 1995
    Geliefert am 01. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as therein defined) (including all liabilities of the company under the debenture)
    Kurze Angaben
    L/H land to the south-east of drayton way daventry northamptonshire t/n NN149910, f/h land to the east of drayton way daventry northamptonshire t/n NN134059 and f/h land to the south side of daux road billingshurst west sussex t/n WSX134050. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1994
    Geliefert am 09. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the guarantee and debenture)
    Kurze Angaben
    Various properties as specified in form 395 (ref:M126). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for Itself,the Arranger,and for Each Bank (As Defined in the Guarantee Anddebenture)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Juni 1993
    Geliefert am 29. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter and the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The properties assets and rights as specified in the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken
    Transaktionen
    • 29. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental composite guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Mai 1993
    Geliefert am 20. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from each obligor (as defined) to the chargees under the terms of the composite guarantee and debenture dated 5.3.93 and the revolving credit facility dated 24.2.93 (as defined)
    Kurze Angaben
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co.Limitedthe "Agent and Arranger"
    • Bank of Scotland
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. März 1993
    Geliefert am 18. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter dated 21 january 1993 and the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    1).Leasehold land to the south east of drayton way daventry northamptonshire and the proceeds of sale thereof 2).freehold land to the east of drayton way daventry northamptonshire 3).freehold land to the south side of daux road billingshurst west sussex.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 18. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 05. März 1993
    Geliefert am 16. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the "finance documents" (as defined)
    Kurze Angaben
    Various properties as specified on form 395 ref M119. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co.Limited
    Transaktionen
    • 16. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. März 1993
    Geliefert am 11. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor named therein to the chargee under the terms of and as defined in the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    See doc ref M107 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Mai 1991
    Geliefert am 30. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of daux rd billingshurst west sussex. T/no. Wsx 134050.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Mai 1991
    Geliefert am 30. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of drayton way daventry northamptonshire t/no. Nn 134059.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1982
    Geliefert am 30. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - unit 1 daux road, billingshurst, west sussex. Tn - 102835.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1982
    Geliefert am 30. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit 1 daux road, billingshurst, W. sussex. Part T.N. - SX70063.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 1981
    Geliefert am 26. Juni 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present future including goodwill & book debts. Uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 1981Registrierung einer Belastung

    Hat CARRINGTON WELDGRIP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Dez. 2010Beginn der Liquidation
    06. Jan. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0