C LIFE PENSIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameC LIFE PENSIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01166185
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von C LIFE PENSIONS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROWN LIFE PENSIONS LIMITED09. Apr. 197409. Apr. 1974

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB* am 29. Aug. 2013

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    8 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    3 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 28,900,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    3 SeitenMR04

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Roger Craine als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Charles Woodcock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHAKESPEARE, Paul
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Sekretär
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Geschäftsführer
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    COLLOFF, Lyn Carol
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    Sekretär
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    British3771140003
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Sekretär
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    LEWIS, Sarah
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Sekretär
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British113431840001
    OSBORNE, Gregory David
    Blackthorn House
    The Drive
    RH14 0TD Ifold Billinghurst
    West Sussex
    Sekretär
    Blackthorn House
    The Drive
    RH14 0TD Ifold Billinghurst
    West Sussex
    British30589910001
    SHAKESPEARE, Paul
    Guttery Close
    Wem
    SY4 5YG Shrewsbury
    2
    Shropshire
    Sekretär
    Guttery Close
    Wem
    SY4 5YG Shrewsbury
    2
    Shropshire
    British135096740001
    BANHAM, Stephen Howard
    Kanungo Lodge
    Friars Rise,Ashwood Road
    GU22 7JL Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kanungo Lodge
    Friars Rise,Ashwood Road
    GU22 7JL Woking
    Surrey
    British34027830001
    BEILES, Herbert Noel
    28 Hanover House
    NW8 7DY London
    Geschäftsführer
    28 Hanover House
    NW8 7DY London
    Canadian7595230001
    BERRYMAN, Malcolm Leonard
    Pilgrims, Clease Way, Compton
    SO21 2AL Winchester
    Geschäftsführer
    Pilgrims, Clease Way, Compton
    SO21 2AL Winchester
    British114331270001
    BURTON, Geoffrey Michael
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    Geschäftsführer
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    British56942980001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    EDGINGTON, James Figg
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    British28278640001
    GREENWOOD, Nicholas John
    Pebblecombe Oatlands Mere
    KT13 9PD Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pebblecombe Oatlands Mere
    KT13 9PD Weybridge
    Surrey
    British1428560001
    HEFER, Andre Viljoen
    54 Beacon Street
    WS13 7AJ Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    54 Beacon Street
    WS13 7AJ Lichfield
    Staffordshire
    South African31916230002
    JOHNSON, Brian Arthur
    3726 Currie Bay
    Regina
    S4S 7C7 Saskatchewan
    Canada
    Geschäftsführer
    3726 Currie Bay
    Regina
    S4S 7C7 Saskatchewan
    Canada
    Canadian37319720001
    KIDNER, John Michael
    22 Chantry Hurst
    Woodcote
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    22 Chantry Hurst
    Woodcote
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British37311990001
    NELSON, Peter
    Sid House Sid Road
    EX10 9AH Sidmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Sid House Sid Road
    EX10 9AH Sidmouth
    Devon
    British27490720001
    REID, Norman Haydn
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    British3771150001
    ROWE, Alan Macdonald
    209-2275 Mcintyre Street
    Regina
    S4P 251 Saskatchewan
    Canada
    Geschäftsführer
    209-2275 Mcintyre Street
    Regina
    S4P 251 Saskatchewan
    Canada
    Canadian37319920001
    SCOTT, Brian
    High Bank House
    Fron Bank Cil-Cewydd Forden
    SY21 8RY Welshpool
    Powys
    Geschäftsführer
    High Bank House
    Fron Bank Cil-Cewydd Forden
    SY21 8RY Welshpool
    Powys
    British77838030001
    WITHEY, Andrew John
    Birchwood Cottage Headley Hill Road
    Headley
    GU35 8DS Bordon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Birchwood Cottage Headley Hill Road
    Headley
    GU35 8DS Bordon
    Hampshire
    British7613090001
    WYBREW, John Leonard
    Hill Farm House
    CW6 0JD Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hill Farm House
    CW6 0JD Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish35286500002
    YATES, Jonathan James
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British51117310003

    Hat C LIFE PENSIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property situate and k/a unit 6 batford mill lower luton road harpenden hertfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 7 batford mill lower luton road harpenden herts and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 7 batford mill lower luton road harpenden hertfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 1991
    Geliefert am 08. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or r a twist and/or s j allan (as trustees) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/a property k/a 3/8 hale road widnes cheshire t/no:- ch 305411.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 17. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 1990
    Geliefert am 21. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £225,000 & all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    1 mentmore terrace london E8 t/n egl 205093 goodwill of the business floating charge over undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Exeter Trust Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 28. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juli 1989
    Geliefert am 03. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    529C and 529D finchley road hampstead london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 12. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 3 river view walnut tree close guildford.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1988
    Geliefert am 01. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that piece of land together with building erected thereon & the parking area adjacent thereto numbered units 2 & 3 st andrews court, st andrews road,droitwich hereford & worcester together with all buildings & fixtures assigns goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 12. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 1988
    Geliefert am 29. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 65000 and all other monies due or to become due from the company and/or allen albert strange and elizabeth anne strange (as trustees)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 5 the townsend centre, blackburn road, houghton regis bedfordshire.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Stor Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 10. Aug. 1987
    Geliefert am 11. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 280000 and all other moneys due or to become due from the company as trustees of the superline tapes co limited directors pensions plan to the chargee under the terms of a facility letter dated 10/2/87 and/or this charge
    Kurze Angaben
    Units 6 and 7 batford mill lower luton road harpenden herts. And all buildings erections fixtures fittings fixed plant & machinery & all other items in the nature of landlords fixtures & fittings and all improvements & additions.
    Berechtigte Personen
    • Hfc Trust & Savings Limited
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 18. Juli 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 1986
    Geliefert am 07. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 75000 and all other moneys due or to become due from the company and/or red/grey limited and/or andrew george millns and/or maurice brian linke to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as 32 englands lane and 25A elizabeths mews hampstead in the london borough of camden title no ngl 427545.
    Berechtigte Personen
    • Norwich General Trust Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 11. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1984
    Geliefert am 12. Juli 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or denis evans and/or michael stewart slade as trustees of the epp pension fund
    Kurze Angaben
    168 cheltenham road, bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 1984Registrierung einer Belastung
    • 28. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 1982
    Geliefert am 21. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 40000
    Kurze Angaben
    2ND and mezzanine floors of the building known as 17/19 neal street, london WC2.
    Berechtigte Personen
    • B J E Spicer
    • S M J Spicer
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    • 17. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Equitable charge
    Erstellt am 13. Nov. 1981
    Geliefert am 01. Dez. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 25000
    Kurze Angaben
    F/Hold 529C and 529D finchley road, london NW3.
    Berechtigte Personen
    • Interphone Limited
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1981Registrierung einer Belastung
    • 22. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat C LIFE PENSIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Aug. 2013Beginn der Liquidation
    11. Juli 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0