DEN HARTOGH UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DEN HARTOGH UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01171859 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEN HARTOGH UK LIMITED?
- Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Verkehr (52290) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Phoenix House Surtees Business Park TS18 3HR Stockton-On-Tees England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DEN HARTOGH LOGISTICS LIMITED | 24. Apr. 2017 | 24. Apr. 2017 |
| INTERBULK (TANKCONTAINERS) LIMITED | 02. Feb. 2009 | 02. Feb. 2009 |
| UNITED TRANSPORT TANK CONTAINERS LIMITED | 26. Juni 2000 | 26. Juni 2000 |
| INITIAL TANKCONTAINERS LTD | 31. März 1998 | 31. März 1998 |
| UNITED TRANSPORT TANKCONTAINERS LIMITED | 03. Mai 1989 | 03. Mai 1989 |
| BAILEE FREIGHT SERVICES LIMITED | 28. Mai 1974 | 28. Mai 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Victoria House Pearson Court Pearson Way Teesdale Stockton Cleveland TS17 6PT zum Phoenix House Surtees Business Park Stockton-on-Tees TS18 3HR am 06. März 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 31 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erf üllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Klaas Pieter Den Hartogh am 10. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Abraham Cornelis Paape als Direktor am 10. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAPE, Abraham Cornelius | Geschäftsführer | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Den Hartogh Uk Limited South Humberside England | Netherlands | Dutch | 205995900001 | |||||
| PIETER DEN HARTOGH, Klaas | Geschäftsführer | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Den Hartogh Uk Limited South Humberside England | Netherlands | Dutch | 205990060001 | |||||
| BROWN, Gareth Trevor | Sekretär | 19 Holbrook School Lane RH12 5PP Horsham West Sussex | British | 15885460002 | ||||||
| CUNNINGHAM, Scott Thomas | Sekretär | Portland Park ML3 7JY Hamilton Athol Bank Lanarkshire Scotland | British | 111223770001 | ||||||
| MOLENAAR, Roelof | Sekretär | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | 70774490001 | ||||||
| SMITH, Diana Jane | Sekretär | Gedempte Zalmhaven 173 FOREIGN 3011 Bt Rotterdam The Netherlands | British | 75147230002 | ||||||
| PLANT NOMINEES LIMITED | Sekretär | Legal Dept Rentokil Initial Uk Ltd RH19 1DY Garland Road, East Grinstead West Sussex | 28712520027 | |||||||
| BOS, Wouter | Geschäftsführer | PO BOX 525 3300 AM Dordrecht The Netherlands | Dutch | 42169500001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Scott Thomas | Geschäftsführer | Pearson Court Pearson Way TS17 6PT Stockton-On-Tees Victoria House Cleveland | Scotland | British | 111223770001 | |||||
| KULLBERG, Loek Frans Jacob | Geschäftsführer | Victoria House Pearson Court Pearson Way TS17 6PT Teesdale Stockton Cleveland | Netherlands | Dutch | 184998400002 | |||||
| MOLENAAR, Roelof | Geschäftsführer | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | 70774490001 | ||||||
| NOEL, Michel | Geschäftsführer | Bergschenhoek Jf Kennedylaan 10 2661jh Netherlands | British | 129561360001 | ||||||
| PATTERSON, Ernest | Geschäftsführer | 1 Hillside Road Penn HP10 8JJ High Wycombe | British | 83721290001 | ||||||
| PEARCH, Nicholas Keith | Geschäftsführer | Bradfield Manor Hullavington SN14 6EU Chippenham Wiltshire | British | 69879060001 | ||||||
| PRATT, Keith | Geschäftsführer | 27 Whernside Ingleby Barwick TS17 0QF Stockton On Tees Cleveland | British | 113151880001 | ||||||
| RICHARDS, Timothy John | Geschäftsführer | Close End Farm Ilmer HP27 9RD Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British,Canadian | 71050390002 | |||||
| SELESKI, Bernardus Kendrikus | Geschäftsführer | PO BOX 11094 3004 EB Rotterdam The Netherlands | Dutch | 33055810001 | ||||||
| SMITH, David Alan | Geschäftsführer | 2 Thirsk Road Stokesley TS9 5BW Middlesbrough Cleveland | British | 33055830002 | ||||||
| SMITH, Diana Jane | Geschäftsführer | Gedempte Zalmhaven 173 FOREIGN 3011 Bt Rotterdam The Netherlands | British | 75147230002 | ||||||
| VAN DER WARDT, Harald Christiaan | Geschäftsführer | Rotterdam 3055 Be Van Hoytemalaan 10 Netherlands | Netherlands | Dutch | 136444450001 | |||||
| WILDE, James Christie Falconer | Geschäftsführer | 38 Box Ridge Avenue CR8 3AQ Purley Surrey | England | British | 36882290001 | |||||
| WILSON, Alan | Geschäftsführer | 20 Westfield Park Elloughton HU15 1AN Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | 147755040001 | |||||
| WISE, Keith | Geschäftsführer | Lothlorien House 19 Southcote Way Penn HP10 8JG High Wycombe Buckinghamshire | British | 94707660001 | ||||||
| WISSEN, Jacobus Cornelis Josef Van | Geschäftsführer | Wielsingel 46 Vj Dud Beijerland 3261 Holland | Netherlands | Dutch | 71933000002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEN HARTOGH UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Klaas Pieter Den Hartogh | 06. Apr. 2016 | 6 Willingestraat 3008PB Rotterdam 6 Netherlands | Nein |
Nationalität: Dutch Staatsangehörigkeit: Netherlands | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat DEN HARTOGH UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 18. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Feb. 2006 Geliefert am 08. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Nov. 2002 Geliefert am 02. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The containers and by way of first assignment the assigned property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Nov. 2002 Geliefert am 02. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. Juni 2000 Geliefert am 13. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Juni 1985 Geliefert am 12. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts f/h property k/a land at stokesley approx. 3 acres at station road and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. März 1985 Geliefert am 13. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at station road stokesley north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0