DEN HARTOGH UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEN HARTOGH UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01171859
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEN HARTOGH UK LIMITED?

    • Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Verkehr (52290) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Phoenix House
    Surtees Business Park
    TS18 3HR Stockton-On-Tees
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DEN HARTOGH LOGISTICS LIMITED24. Apr. 201724. Apr. 2017
    INTERBULK (TANKCONTAINERS) LIMITED02. Feb. 200902. Feb. 2009
    UNITED TRANSPORT TANK CONTAINERS LIMITED26. Juni 200026. Juni 2000
    INITIAL TANKCONTAINERS LTD31. März 199831. März 1998
    UNITED TRANSPORT TANKCONTAINERS LIMITED03. Mai 198903. Mai 1989
    BAILEE FREIGHT SERVICES LIMITED 28. Mai 197428. Mai 1974

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 12. März 2020

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    24 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Victoria House Pearson Court Pearson Way Teesdale Stockton Cleveland TS17 6PT zum Phoenix House Surtees Business Park Stockton-on-Tees TS18 3HR am 06. März 2019

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2018

    • Kapital: GBP 0.01
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    31 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Apr. 2017

    RES15

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Klaas Pieter Den Hartogh am 10. März 2016

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Abraham Cornelis Paape als Direktor am 10. März 2016

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PAAPE, Abraham Cornelius
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    Geschäftsführer
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutch205995900001
    PIETER DEN HARTOGH, Klaas
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    Geschäftsführer
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutch205990060001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    British15885460002
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    Sekretär
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    British111223770001
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Sekretär
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Dutch70774490001
    SMITH, Diana Jane
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    Sekretär
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    British75147230002
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Legal Dept
    Rentokil Initial Uk Ltd
    RH19 1DY Garland Road, East Grinstead
    West Sussex
    Sekretär
    Legal Dept
    Rentokil Initial Uk Ltd
    RH19 1DY Garland Road, East Grinstead
    West Sussex
    28712520027
    BOS, Wouter
    PO BOX 525
    3300 AM Dordrecht
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    PO BOX 525
    3300 AM Dordrecht
    The Netherlands
    Dutch42169500001
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Pearson Court
    Pearson Way
    TS17 6PT Stockton-On-Tees
    Victoria House
    Cleveland
    Geschäftsführer
    Pearson Court
    Pearson Way
    TS17 6PT Stockton-On-Tees
    Victoria House
    Cleveland
    ScotlandBritish111223770001
    KULLBERG, Loek Frans Jacob
    Victoria House
    Pearson Court Pearson Way
    TS17 6PT Teesdale Stockton
    Cleveland
    Geschäftsführer
    Victoria House
    Pearson Court Pearson Way
    TS17 6PT Teesdale Stockton
    Cleveland
    NetherlandsDutch184998400002
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Dutch70774490001
    NOEL, Michel
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    British129561360001
    PATTERSON, Ernest
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    Geschäftsführer
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    British83721290001
    PEARCH, Nicholas Keith
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    British69879060001
    PRATT, Keith
    27 Whernside Ingleby
    Barwick
    TS17 0QF Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    27 Whernside Ingleby
    Barwick
    TS17 0QF Stockton On Tees
    Cleveland
    British113151880001
    RICHARDS, Timothy John
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish,Canadian71050390002
    SELESKI, Bernardus Kendrikus
    PO BOX 11094
    3004 EB Rotterdam
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    PO BOX 11094
    3004 EB Rotterdam
    The Netherlands
    Dutch33055810001
    SMITH, David Alan
    2 Thirsk Road
    Stokesley
    TS9 5BW Middlesbrough
    Cleveland
    Geschäftsführer
    2 Thirsk Road
    Stokesley
    TS9 5BW Middlesbrough
    Cleveland
    British33055830002
    SMITH, Diana Jane
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    British75147230002
    VAN DER WARDT, Harald Christiaan
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    NetherlandsDutch136444450001
    WILDE, James Christie Falconer
    38 Box Ridge Avenue
    CR8 3AQ Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    38 Box Ridge Avenue
    CR8 3AQ Purley
    Surrey
    EnglandBritish36882290001
    WILSON, Alan
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish147755040001
    WISE, Keith
    Lothlorien House
    19 Southcote Way Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lothlorien House
    19 Southcote Way Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    British94707660001
    WISSEN, Jacobus Cornelis Josef Van
    Wielsingel 46
    Vj Dud Beijerland
    3261
    Holland
    Geschäftsführer
    Wielsingel 46
    Vj Dud Beijerland
    3261
    Holland
    NetherlandsDutch71933000002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Klaas Pieter Den Hartogh
    6 Willingestraat
    3008PB Rotterdam
    6
    Netherlands
    06. Apr. 2016
    6 Willingestraat
    3008PB Rotterdam
    6
    Netherlands
    Nein
    Nationalität: Dutch
    Staatsangehörigkeit: Netherlands
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DEN HARTOGH UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 18. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 08. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Secured Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Nov. 2002
    Geliefert am 02. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The containers and by way of first assignment the assigned property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Nov. 2002
    Geliefert am 02. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Juni 2000
    Geliefert am 13. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Agent, the Banks, the Hedging Banks and the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 13. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Juni 1985
    Geliefert am 12. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts f/h property k/a land at stokesley approx. 3 acres at station road and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 04. März 1985
    Geliefert am 13. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises at station road stokesley north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0