CONVOTHERM LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CONVOTHERM LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01172730 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONVOTHERM LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CONVOTHERM LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONVOTHERM LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
REGETHERMIC U.K. LIMITED | 05. Juni 1974 | 05. Juni 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONVOTHERM LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONVOTHERM LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 5 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Aug. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kachmer als Geschäftsführer am 03. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 29. März 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONVOTHERM LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | Accountant | 146072380001 | ||||||||
JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | Company Director | 134328700001 | ||||||||
VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | Business Development Director | 43215170003 | ||||||||
CLAYTON, Gilbert Falkingham | Sekretär | 93 High Street TW12 1NH Hampton Hill Middlesex | British | 89624880001 | ||||||||||
DOBBS, Richard Noel | Sekretär | 19 Haygarth Place SW19 5BX London | British | 8685710001 | ||||||||||
GEORGESON, Ian Barry | Sekretär | 40a Danehurst Street SW6 6SD London | British | 25947220001 | ||||||||||
SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
WARD, Elaine Florence Maud | Sekretär | 68 Abbey Road Westbury On Ttrym BS9 3QR Bristol | British | 51001180001 | ||||||||||
WEBSTER, Randall Lewis | Sekretär | St Helier 29 Wideatts Road BS27 3AT Cheddar Somerset | British | Sales Manager | 46406420001 | |||||||||
BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | Accountant | 79449700002 | ||||||||
BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Oakwoods Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Cambridgeshire | British | Accountant | 79449700001 | |||||||||
CLAYTON, Gilbert Falkingham | Geschäftsführer | 93 High Street TW12 1NH Hampton Hill Middlesex | British | Acountant | 89624880001 | |||||||||
DIBBEN, John Mervyn Farquhar | Geschäftsführer | Morley Farm Eastcourt SN16 9HN Malmesbury Wiltshire | British | Company Director | 10193310003 | |||||||||
DITTMAN, Frank | Geschäftsführer | Farbergasse 33 82362 Weilheim Germany | German | Joint Managing Director | 52478690001 | |||||||||
DOBBS, Richard Noel | Geschäftsführer | 19 Haygarth Place SW19 5BX London | British | Accountant | 8685710001 | |||||||||
DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | Solicitor | 134081280001 | |||||||||
HERRMANN, Harvey Stuart | Geschäftsführer | 27 Leyborne Park Kew TW9 3HB Richmond Surrey | England | British | Company Director | 23164010001 | ||||||||
HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | Company Secretary | 17023730002 | |||||||||
HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | Company Secretary | 17023730001 | |||||||||
HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | Company Secretary | 17023730001 | |||||||||
KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | Company Director | 136570610001 | ||||||||
LEE, Paul Allan | Geschäftsführer | Clifton Park Road Caversham RG4 7PD Reading 4 Berkshire | England | British | Director Of Corporate Control | 70564410001 | ||||||||
LOUGHTON, Stephen Andrew | Geschäftsführer | Rivendell Middleton Road GU15 3TU Camberley Surrey | England | British | Managing Director | 30589020001 | ||||||||
LOWERY, Robert Johnson | Geschäftsführer | 1 Devonshire Gardens Grove Park Chiswick W4 3TW London | British | Company Director | 10629590001 | |||||||||
ROLT, Jeremy Charles | Geschäftsführer | 4 Sycamore Close St Ippolyts SG4 7SN Hitchin Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 35716980001 | ||||||||
SCHWARZBACKER, Werner | Geschäftsführer | Kerschgarten 3 82436 Untereglfing Germany | German | Joint Managing Director | 52478970001 | |||||||||
TONER, Robert Anthony | Geschäftsführer | 29 Lamb Close WD25 0TB Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | Director Corporate Planning | 70516300002 | ||||||||
WEBSTER, Randall Lewis | Geschäftsführer | St Helier 29 Wideatts Road BS27 3AT Cheddar Somerset | British | Sales Manager | 46406420001 | |||||||||
BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Hat CONVOTHERM LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 19. Apr. 1995 Geliefert am 21. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 09. Jan. 1995 Geliefert am 18. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the rent deposit deed | |
Kurze Angaben Rent deposit monies in the sum of £5,000 and interest accrued thereon referred to in the rent deposit deed dated 9 january 1995. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 05. Jan. 1988 Geliefert am 22. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all propety and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Feb. 1984 Geliefert am 08. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h proeprties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0