EDLAW NO. 5 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EDLAW NO. 5 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01176715 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EDLAW NO. 5 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich EDLAW NO. 5 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EDLAW NO. 5 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MARIN-ARK LIMITED | 21. Feb. 2002 | 21. Feb. 2002 |
S. & J. WALSH (PLASTICS) LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
ARMORIDE LIMITED | 09. Juli 1974 | 09. Juli 1974 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDLAW NO. 5 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EDLAW NO. 5 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bettws Road Llangeinor Bridgend Mid Glamorgan CF32 8PL am 18. Okt. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Richard Howells als Sekretär am 30. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Richard Howells als Geschäftsführer am 30. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Deborah Janet Wilkinson am 27. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Richard Howells am 27. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Richard Howells am 27. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2010 bis 30. Juni 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von EDLAW NO. 5 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKINSON, Deborah Janet | Geschäftsführer | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London Kpmg Llp | United Kingdom | British | Finance Director | 88411860004 | ||||
BOLTER, Roger Christopher | Sekretär | Sheepleys Llandow CF71 7PA Cowbridge Vale Of Glamorgan | British | Accountant | 78969400005 | |||||
HOAD, Geoffrey Douglas | Sekretär | 23 North Street CM6 1AZ Great Dunmow Essex | British | 48622020001 | ||||||
HOWELLS, David Richard | Sekretär | Bettws Road Llangeinor CF32 8PL Bridgend Mid Glamorgan | British | Asst Grp Financial Director | 110640670001 | |||||
WILKINSON, Deborah Janet | Sekretär | Heol Y Cwrt North Cornelly CF33 4AX Bridgend 43 Mid Glamorgan | British | Financial Controller | 88411860003 | |||||
WILMAN, David John | Sekretär | Kylemore 4 The Cranagh Warren Road BT21 0ET Donaghadee | British | 22174080002 | ||||||
WILMAN, David John | Sekretär | 15 Wentworth Close Hadleigh IP7 5SA Ipswich Suffolk | British | 22174080001 | ||||||
BOLTER, Roger Christopher | Geschäftsführer | Sheepleys Llandow CF71 7PA Cowbridge Vale Of Glamorgan | Wales | British | Accountant | 78969400005 | ||||
EARP, John | Geschäftsführer | 43 Church Meadows BT25 1LZ Dromore County Down | British | Chartered Accountant | 67307010002 | |||||
HOWELLS, David Richard | Geschäftsführer | Bettws Road Llangeinor CF32 8PL Bridgend Mid Glamorgan | Wales | British | Asst Group Financial Director | 110640670001 | ||||
MCCHESNEY, William Samuel | Geschäftsführer | 3 Hampton Court BT38 9DT Carrickfergus County Antrim | United Kingdom | British | Director | 69155740001 | ||||
NUWAR, David | Geschäftsführer | 12 Penarth Portway CF64 1SQ Penarth Vale Of Glamorgan | British | Director | 112290260001 | |||||
TAYLOR, Brian Reginald | Geschäftsführer | The Manor Marten SN8 3SJ Marlborough Wiltshire | England | British | Company Director | 2197890003 | ||||
THOMAS, Philip | Geschäftsführer | 57 Bryneglwys Gardens CF36 5PR Porthcawl Mid Glamorgan | British | Managing Director | 95171100001 | |||||
WILMAN, David John | Geschäftsführer | Kylemore 4 The Cranagh Warren Road BT21 0ET Donaghadee | United Kingdom | British | Company Director | 22174080002 |
Hat EDLAW NO. 5 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 25. Jan. 2002 Geliefert am 12. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) in any currency whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including land and premises at kingsway,dunmurry,belfast; la 393060; land and premises at 1,2 and 3 beaufort rd,birkenhead, ms 278694; land and premises at brunel rd,newton abbot,devon; dn 113225; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture of even date between troyess PLC (the parent) edlaw PLC (the company) the companies listed in the schedule 1 of the debenture (the charging companies) and the chargee | Erstellt am 27. Apr. 2001 Geliefert am 08. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the subordinated finance documents (as defined) on any account | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed of accession to a debenture dated 17 november 1999 as amended by a deed of amendment dated 26 january 2000 and a deed of accession and amendment dated 15 march 2000 | Erstellt am 17. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from the company and each of the obligors to the chargee under the finance documents (or any of them) and this debenture and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The key properties together with all buildings and fixtures (as defined). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. März 1982 Geliefert am 15. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill &book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Okt. 1981 Geliefert am 17. Nov. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all freehold or leasehold properties. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat EDLAW NO. 5 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0