FLEXTECH (1992) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEXTECH (1992) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01190025
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEXTECH (1992) LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FLEXTECH P L C31. Dez. 197831. Dez. 1978
    FLEXTECH OIL PIPE (HOLDINGS) LIMITED08. Nov. 197408. Nov. 1974

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 31. Mai 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 02. Mai 2018

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    legacy

    80 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Notification of General Cable Limited as a person with significant control on 04. Juli 2017

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Flextech Broadband Limited as a person with significant control on 04. Juli 2017

    1 SeitenPSC07

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 08. Mai 2017

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium & merger reserve be reduced. 27/04/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    17 SeitenAA

    legacy

    85 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    151021080001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Sekretär
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Sekretär
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Sekretär
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRETT, Stephen Marc
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    Geschäftsführer
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    American21673650001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Geschäftsführer
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    KOPPEL, Montague
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Geschäftsführer
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British63610140001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Geschäftsführer
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAMPTON, Jack Leslie, Sir
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    British13438080001
    SINGER, Adam Nicholas
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    British35783020005
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British93064740002
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TINDALE, Lawrence Victor Dolman
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    British629850001
    TORRINGTON, Timothy Howard St George, The Viscount
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO21 1JL Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO21 1JL Winchester
    Hampshire
    British3107510001
    VELJANOVSKI, Cento Gavril
    Apartment 12b Block 1
    Pacific View Tai Tam Road
    SW3 5UW Hong Kong
    Geschäftsführer
    Apartment 12b Block 1
    Pacific View Tai Tam Road
    SW3 5UW Hong Kong
    Australian70365330001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Geschäftsführer
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    YASSUKOVICH, Stanislas Michael
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    Geschäftsführer
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    American39995940002
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FLEXTECH (1992) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    04. Juli 2017
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4925679
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4125315
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FLEXTECH (1992) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 10. Mai 2005
    Geliefert am 18. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 18. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 23. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest in and to all the rights and to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 23. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 05. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts payable to the chargee to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any security documents (as defined) and all indebtedness by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents (as defined) and to the hedge counterparties under the hedging arrangements and all indebtedness of the lessors (or any of them) under the lease documents and all obligations due to crosby under the crosby documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the secured assets (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cib World Markets PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) telewest finance corporation (the "us "borrower") 5). cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company.
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 23. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A).all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    I). all the company's present and future rights, title, benefit and interest in and under the loan stock (as defined) from time to time ii).all rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company arising under the bbc jv management services agreement, and the UK gold jv management services agreement iii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company under the bbc jv agreement,the UK gold jv agreement and any other subscription and shareholder agreement entered into in relation to a joint venture,including (but not limited to) all amounts payable under clauses 19 and 20 of the bbc jv agreement and clauses 19 and 20 of the UK gold jv agreement and iv). All the company's present and future rights title benefit and interest in and under the intercompany loan agreement together with first floating charge all the company's undertaking property and assets not charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights assets or property secured in favour of the security trustee pursuant to the security agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 06. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    By CLAUSE2.1 Of the security agreement the company covenants that it will pay to the security trustee for the account of the beneficiaries all moneys and discharge all obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the beneficiaries or any of them under or pursuant to the credit facility agreement
    Kurze Angaben
    By clause 2.2 of the security agreement the company as sole beneficial owner to the intent that the security trustee shall have a security interest in all of the company's right title and interest in and to the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank(As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    All the undertaking goodwill property assets and rights of such chargor as specified in the debenture (the "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank(In It's Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 17. Apr. 1997
    Geliefert am 30. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities now or hereafter due ,owing or incurred from the company to the chargee in it's capacity as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to the beneficiaries or any of them under or pursuant to the credit facility agreement and this security agreement
    Kurze Angaben
    The security assets being the shares and all dividends bonuses and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 17. Apr. 1997
    Geliefert am 30. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities now or hereafter due ,owing or incurred from the company to the chargee in it's capacity as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to the beneficiaries or any of them under or pursuant to the credit facility agreement and this security agreement
    Kurze Angaben
    The securtiyb assets being the shares and all dividends bonuses and other rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share security agreement (dated 11TH april 1997 and 17TH april 1997)
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 28. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to any of the transaction documents as defined in this share security agreement
    Kurze Angaben
    All stocks, shares, securities, rights, monies or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights, conversion, purchase, warrant rights or otherwise in respect of the 3,619,543 ordinary shares of 10P each (the "security shares") in the capital of scottish television public limited company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement
    Erstellt am 27. Sept. 1995
    Geliefert am 09. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (all such terms as defined in the loan agreement dated 30TH august 1995 as amended by supplemental loan agreement dated 27TH september 1995) or any one or more of them under the loan agreement, the other security documents (as defined in the loan agreement) (if any) and in the share pledge
    Kurze Angaben
    12,065,143 ordinary shares of 10 each of scottish television PLC (the shares) and all stocks shares securities rights monies or property accruing or offered. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Memorandum of charge.
    Erstellt am 30. Mai 1979
    Geliefert am 31. Mai 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All present & future monies standing to company's credit in books of banque nationale de paris limited.
    Berechtigte Personen
    • Banque Nationale De Paris Limited
    Transaktionen
    • 31. Mai 1979Registrierung einer Belastung
    • 24. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FLEXTECH (1992) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Aug. 2019Aufgelöst am
    02. Mai 2018Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0