SIMBEC RESEARCH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIMBEC RESEARCH LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01191772
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    • Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten n.a. (74909) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Simbec House Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Mid Glamorgan
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis14. Mai 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung28. Mai 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis14. Mai 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Eintragung der Belastung 011917720022, erstellt am 03. Dez. 2024

    63 SeitenMR01

    Ernennung von Miss Charlotte Anne Osmond als Sekretär am 17. Sept. 2024

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von John Richard Gahan als Geschäftsführer am 29. Aug. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    25 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mark Joseph Trus als Direktor am 21. Mai 2024

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    25 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Ms Ceri Elizabeth Edwards als Direktor am 01. Jan. 2023

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    26 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    30 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    29 SeitenAA

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Simbec House Merthyr Tydfil Industrial Park Pentrebach Merthyr Tydfil Mid Glamorgan CF48 4DR verlegt

    1 SeitenAD04

    Eintragung der Belastung 011917720021, erstellt am 26. Juni 2020

    63 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Hemant Patel als Geschäftsführer am 31. März 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Ronald Openshaw als Geschäftsführer am 16. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    26 SeitenAA

    Ernennung von Mr Hemant Patel als Direktor am 28. Juni 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr John Richard Gahan als Direktor am 28. Juni 2019

    2 SeitenAP01

    Notification of Cbpe Capital Llp as a person with significant control on 03. Juni 2019

    2 SeitenPSC02

    Notification of Cbpe Capital Ix Gp Llp as a person with significant control on 03. Juni 2019

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OSMOND, Charlotte Anne
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    327558670001
    CHARTIER, Fabrice Guy, Dr
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    FranceFrenchScientific Director56880800004
    EDWARDS, Ceri Elizabeth
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    WalesBritishManaging Director, Clinical Pharmacology304977870001
    TRUS, Mark Joseph
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    United StatesCanadianChief Financial Officer323478430001
    FEATHER, David Robert Eliis
    Yew Tree Cottage
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    Sekretär
    Yew Tree Cottage
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    BritishFinancial Accountant39337360001
    HALLISEY, Brian
    Ton Newydd
    4 The Grove
    CF47 8YR Merthyr Tydfil
    Sekretär
    Ton Newydd
    4 The Grove
    CF47 8YR Merthyr Tydfil
    British58805550001
    HILL, Alan
    82 Kings Ride
    GU15 4LN Camberley
    Surrey
    Sekretär
    82 Kings Ride
    GU15 4LN Camberley
    Surrey
    British8695550001
    JENKINS, Howard Rhys
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Sekretär
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    177986330001
    JENKINS, Howard Rhys
    1 The Coppice
    Tudor Mews
    CF72 8SU Miskin
    Pontyclun
    Sekretär
    1 The Coppice
    Tudor Mews
    CF72 8SU Miskin
    Pontyclun
    BritishFinance Director90832830002
    MORAS, Yves
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Unit 29
    Mid Glamorgan
    Wales
    Sekretär
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Unit 29
    Mid Glamorgan
    Wales
    172481380001
    PICARD, Alexandra
    Bath Road
    SL1 3UA Slough
    7 Bath Road
    England
    Sekretär
    Bath Road
    SL1 3UA Slough
    7 Bath Road
    England
    198856800001
    BELLEVILLE, Maryse
    27 Avenue Lacassgne
    Residense Floretien
    FOREIGN Lyon 69003
    France
    Geschäftsführer
    27 Avenue Lacassgne
    Residense Floretien
    FOREIGN Lyon 69003
    France
    FrenchManager27524900001
    BOISVERT, Marie-Claude
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    CanadaCanadianBusinesswoman154933040001
    BON HOMME, Yves
    21 Avenue De La Paix
    Le Buclay
    FOREIGN Charbonnieres 69260
    France
    Geschäftsführer
    21 Avenue De La Paix
    Le Buclay
    FOREIGN Charbonnieres 69260
    France
    FrenchResearch Chemist27524890001
    BOUVIER, Pierre-Francois
    2 Rue Tete D`Or
    69006 Lyon
    France
    Geschäftsführer
    2 Rue Tete D`Or
    69006 Lyon
    France
    FrenchManager33800070001
    CAILLE, Louis
    De Franchimont
    Blainville
    38
    Quebec
    Canada
    Geschäftsführer
    De Franchimont
    Blainville
    38
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadianBusinessman133330520001
    EVANS, Christopher Thomas, Professor
    c/o Excalibur Group Holdings Limited
    Berkeley Square
    W1J 6BD London
    Berkeley Square House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Excalibur Group Holdings Limited
    Berkeley Square
    W1J 6BD London
    Berkeley Square House
    England
    United KingdomBritishEntrepreneur159856400001
    GAGNON, Nathalie
    De Lavande
    Laval H7y 2g6
    1023
    Quebec
    Canada
    Geschäftsführer
    De Lavande
    Laval H7y 2g6
    1023
    Quebec
    Canada
    CanadianCfo133329820001
    GAHAN, John Richard
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    EnglandBritishDirector258039920001
    HALL, Frank Matthew Sunderland
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    EnglandAustralianChief Financial Officer97103350001
    HALLISEY, Brian
    Ton Newydd
    4 The Grove
    CF47 8YR Merthyr Tydfil
    Geschäftsführer
    Ton Newydd
    4 The Grove
    CF47 8YR Merthyr Tydfil
    BritishDirector58805550001
    JENKINS, Howard Rhys
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritishCompany Director90832830002
    JENKINS, Howard Rhys
    1 The Coppice
    Tudor Mews
    CF72 8SU Miskin
    Pontyclun
    Geschäftsführer
    1 The Coppice
    Tudor Mews
    CF72 8SU Miskin
    Pontyclun
    United KingdomBritishFinance Director90832830002
    JONES, Trevor Mervyn
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishCompany Director183134040001
    JULLIARD, Jean-Noel
    6 Chemin De Chavril
    Sainte Foy Les Lyon
    FOREIGN 69110 France
    Geschäftsführer
    6 Chemin De Chavril
    Sainte Foy Les Lyon
    FOREIGN 69110 France
    FrenchAccountant59337400001
    LA FORGE, Andre
    Brock Avenue North
    Montreal-West H4x 2g4
    309
    Quebec
    Canada
    Geschäftsführer
    Brock Avenue North
    Montreal-West H4x 2g4
    309
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadianBusinessman133330320001
    MADDOCK, Jeffrey
    3 Gobannium Way
    Ysbytty Fields
    NP7 9JA Abergavenny
    Gwent
    Geschäftsführer
    3 Gobannium Way
    Ysbytty Fields
    NP7 9JA Abergavenny
    Gwent
    BritishResearch Chemist43405600001
    MAUDE, John Bagshaw
    The Spinney Chequers Lane
    Preston
    SG4 7TX Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Spinney Chequers Lane
    Preston
    SG4 7TX Hitchin
    Hertfordshire
    BritishPharmacist27606760001
    MEYNAUD, Andre
    24 Rue Dellevaux
    Champagne Au Mont D'Or
    FOREIGN 69410 France
    Geschäftsführer
    24 Rue Dellevaux
    Champagne Au Mont D'Or
    FOREIGN 69410 France
    FrenchBiochemist59337440001
    MORAS, Yves
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Unit 29
    Mid Glamorgan
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Unit 29
    Mid Glamorgan
    United Kingdom
    WalesCanadianManaging Director172481450001
    OPENSHAW, James Ronald
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritishChief Executive208059250001
    OPENSHAW, James Ronald
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    United KingdomBritishChief Executive208059250001
    PATEL, Hemant
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    EnglandBritishDirector291060740001
    PEEL, Doug
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    CanadaCanadianBusinessman155002680001
    TANNER, Trevor
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritishCompany Director91878050001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIMBEC RESEARCH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cbpe Capital Llp
    George Yard
    EC3V 9DH London
    2
    England
    03. Juni 2019
    George Yard
    EC3V 9DH London
    2
    England
    Nein
    RechtsformEnglish Limited Liability Partnership
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House In England And Wales
    RegistrierungsnummerOc305899
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Cbpe Capital Ix Gp Llp
    George Yard
    EC3V 9DH London
    2
    England
    03. Juni 2019
    George Yard
    EC3V 9DH London
    2
    England
    Nein
    RechtsformEnglish Limited Liability Partnership
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House In England And Wales
    RegistrierungsnummerOc398673
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Simbec-Orion Group Limited
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Wales
    06. Apr. 2017
    Merthyr Tydfil Industrial Park
    Pentrebach
    CF48 4DR Merthyr Tydfil
    Simbec House
    Wales
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RechtsgrundlageEngland And Wales Law
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat SIMBEC RESEARCH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Dez. 2024
    Geliefert am 05. Dez. 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc UK Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Juni 2020
    Geliefert am 02. Juli 2020
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc UK Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Agent)
    Transaktionen
    • 02. Juli 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Jan. 2019
    Geliefert am 04. Feb. 2019
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Not applicable.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Okt. 2017
    Geliefert am 15. Nov. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Simbec house, merthry tydfil industrial park, merthyr tydfil t/no WA664222, WA400851 and CYM142774.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Arix Bioscience Holdings Limited
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juni 2014
    Geliefert am 01. Juli 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juni 2014
    Geliefert am 19. Juni 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The freehold property known as simbec house, merthyr tydfil industrial park, merthyr tydfil (also known as land lying to the south west of merthyr road, merthyr tydfil) registered at the land registry with title numbers WA664222, WA400851 and CYM142774.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juni 2014
    Geliefert am 19. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    (A) the freehold property known as simbec house, merthyr tydfil industrial park, merthyr tydfil (also known as land lying to the south west of merthyr road, merthyr tydfil) registered at the land registry with title numbers WA664222, WA400851 and CYM142774.. (B) all present and future interests of the company in, or over, any other freehold or leasehold property.. (C) the company's present and future patents, trade marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wales Life Sciences Investment Fund LP (Acting by Its General Partner Arthurian Life Sciences Spv Gp Limited)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Juni 2013
    Geliefert am 18. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The f/h property known as simbec house, merthyr tydfil industrial park, merthyr tydfil (also known as land lying to the south west of merthyr road, merthyr tydfil), t/no: WA664222, WA400851, CYM142774. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wales Life Sciences Investment Fund LP (Acting by Its General Partner Arthurian Life Sciences Spv Gp Limited)
    Transaktionen
    • 18. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Mai 2013
    Geliefert am 03. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1. the freehold property known as simbec house, merthyr tydfil industrial park, merthyr tydfil (also known as land lying to the south west of merthyr road, merthyr tydfil) registered at the land registry with title numbers WA664222, WA400851 and CYM142774.. 2. all present and future interests of simbec research limited (the "grantor") in, or over, freehold or leasehold property.. 3. the grantor's present and future patents, trade marks, service marks, trade names, designs, copyrights, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know-how and any interest in any of these rights, whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wales Life Sciences Investment Fund LP Acting by Its General Partner Arthurian Life Sciences Spv Gp Limited
    Transaktionen
    • 03. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 12. Feb. 2013
    Geliefert am 27. Feb. 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Algorithme Pharma Inc.
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 2008
    Geliefert am 17. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and/or any of the other lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 20. Okt. 2003
    Geliefert am 24. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex Lawrie Factors
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2003
    Geliefert am 04. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a merthyr tydfil industrial park merthyr t/nos WA664222 and WA400851 by way of fixed charge all plant machinery implements utensils, the goodwill by way of assignment the benefit of all covenants rights and agreements.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a simbec research limited merthyr tydfil industrial estate, merthyr tydfil CF48 4DR. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 13. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at simbec house merthyr tydfil mid glamorgan t/n's WA664222 and WA400851 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 13. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at simbec house merthyr tydfil mid glamorgan and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Juni 1983
    Geliefert am 01. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    • 14. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1981
    Geliefert am 23. März 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 148 high street, merthyr tydfil, mid glam.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1981Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 12. März 1980
    Geliefert am 20. März 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H laboratories & factory at cefn coed, merthyr tydfil, mid glam. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1980Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 12. März 1980
    Geliefert am 20. März 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H merthyr tydfil industrial park, troedyrhiw, merthyr tydfil, mid glam. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1980Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1980
    Geliefert am 01. Feb. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land part of cefn cottage cefn coed mid glam together with all fixtures land at merthyr tydfil industrial park troedyrhiw, merthyr tydfil mid glam. Together with all fixtures fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Wales
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0