WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED

WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01194273
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO LLP
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LANLEY BUILDERS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR zum C/O Bdo Llp 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD am 04. Feb. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Jan. 2015

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 14. Mai 2014

    • Kapital: GBP 8,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Karen Atterbury als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr. Michael Andrew Lonnon als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für James John Jordan am 28. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Lorraine Atterbury am 28. März 2011

    2 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 80 New Bond Street London W1S 1SB United Kingdom* am 30. März 2011

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Carney als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH England geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Carney am 09. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    166014510001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    JORDAN, James John
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish120602100002
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British175715660001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Sekretär
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DE FEO, Caterina
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    British58246930001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Sekretär
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Sekretär
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    MORRISON, Alistair Horne
    9 Forest Way
    Bromley Cross
    BL7 9YE Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    9 Forest Way
    Bromley Cross
    BL7 9YE Bolton
    Lancashire
    British3712720001
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Sekretär
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    TOGHILL, Stephen Timothy
    1 Hartington Drive
    Standish
    WN6 0UA Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    1 Hartington Drive
    Standish
    WN6 0UA Wigan
    Lancashire
    British62195170001
    AINSCOUGH, William
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish18332250011
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    EVANS, David Richard
    Ty Newydd Farm
    Ffordd Nercwys Treuddyn
    CH7 4BG Mold
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Ty Newydd Farm
    Ffordd Nercwys Treuddyn
    CH7 4BG Mold
    Clwyd
    British20424380001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Geschäftsführer
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritish76720550003
    HARDY, Gary John
    8 Milnholme
    Smithills
    B4 6TB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Milnholme
    Smithills
    B4 6TB Bolton
    Lancashire
    British52900300002
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8895880004
    MORRISON, Alistair Horne
    9 Forest Way
    Bromley Cross
    BL7 9YE Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Forest Way
    Bromley Cross
    BL7 9YE Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish3712720001
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    British115863170001
    OWEN, Stephen John
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish66776040001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Geschäftsführer
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritish75750250002
    SMITH, Ronald
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    Geschäftsführer
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    British5826110001
    TUTTE, John Frederick
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish56012720002
    WATTS, Christopher Philip
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    British83391430001
    WILBY, Anthony
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    Geschäftsführer
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    British93928430001

    Hat WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of offset
    Erstellt am 21. Feb. 1992
    Geliefert am 02. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due from the companies named therein to the chargee on any account whatsover
    Kurze Angaben
    The balance at credit of any accounts held by the chargee.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1990
    Geliefert am 15. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a road on the north west side of hunters drive ighlenhill burnely.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or whelmar group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land east and west side of wellfield drive ighton hill burnley lancashire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or whelmar group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at runshaw lane west of church park north buxton chorley lancashire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or whelmar group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H park road kirkham preston lancashire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or whelmar group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the east of bentham street blackburn lancashire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or whelmar group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north east of pool house lane ingol preston lancashire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Mai 1989
    Geliefert am 22. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of offset
    Erstellt am 12. Mai 1989
    Geliefert am 22. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Please view deed and companies referred to in the schedule of letter of offset (for details see doc 395/m/218/c/24/5 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 1988
    Geliefert am 04. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that plot of f/h land situate on the west of wellfield drive ighteshill burnley lancashire fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Apr. 1988
    Geliefert am 05. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £200,000
    Kurze Angaben
    F/H land on the west of wellfield drive ighteshill burnley lancs t/no la 362400.
    Berechtigte Personen
    • Colroy Properties Limited
    Transaktionen
    • 05. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 15. Feb. 1988
    Geliefert am 15. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Further advances & all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land situate on the east side of school lane leyland lancashire containing 3.29 acres or thereabouts.
    Berechtigte Personen
    • Halifax Building Society
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 13. Feb. 1987
    Geliefert am 14. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the benefit of the agreement relating to land lying to the west side of station road bamber bridge preston lancashire dated 1-12-86 all the debts of the company present & future arising from the sales or disposals of the said land (please see doc 395 m 259/23 feb/cf for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 1986
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/hold land containing 7414 square yards or thereabouts situate at the junction of county road and burscough road, ormskirk, west lancashire, lancashire. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 1986
    Geliefert am 26. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at golden hill lane leyland south rebble lancashire t/no 537799 together with plant, machinery and fixtures and fittings, furniture, equipment, implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 1986
    Geliefert am 26. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land and buildings at golden hill lane leyland south ribble lancashire la 527799 fixed charge plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of a charge
    Erstellt am 18. Apr. 1986
    Geliefert am 22. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the benefit of the building agreement and licence relating to land at parcel 26 moss side leyland lancashire (for further details please see doc M33).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of a charge
    Erstellt am 08. Apr. 1986
    Geliefert am 22. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the benefit of the building licence agreement dated 1ST september 1986 relating to land containing 1.76 nectores or thereabouts situate at carr brook wood end clayton-le-woods chorley lancashire (for further details please see doc M35).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 08. Apr. 1986
    Geliefert am 22. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the benefit of the building licence agreement relating to land at parcel c eaves green chorley lancashire (for furter details please see doc M34).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 1985
    Geliefert am 10. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land together with the buildings erected thereon and known as the grove longton south ribble lancashire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 1985
    Geliefert am 03. Aug. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land containing 1.70 acres or thereabouts and situate at runshaw lane euxton chorley lancashire together with all fixtures whatsoever new or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 1985
    Geliefert am 06. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £55,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Land in runshaw lane, euxton, chorley, lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Mrs Aris Hill
    Transaktionen
    • 06. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 14. Dez. 1984
    Geliefert am 21. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the benefit of the agreement relating to land situate at golden hill lane leyland lancasire containing in the whole 7.32 acres or thereabout dated 21 june 84. (see doc M29 for details).
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Assignment
    Erstellt am 06. Juli 1983
    Geliefert am 06. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    For details please see (doc M28).
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Assignment
    Erstellt am 06. Juli 1983
    Geliefert am 06. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to from woodrose limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the building licence agreement in sofar as relates to land at car brook wood end chorley lancs etc all other relevant information please see (doc M27).
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 1983Registrierung einer Belastung

    Hat WAINHOMES (LANCASHIRE) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Jan. 2016Aufgelöst am
    21. Jan. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0