CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED

CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01196227
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP am 24. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Sharon Jill Caterer am 23. Juni 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    18 SeitenAA

    Ernennung von Rbs Secretarial Services Limited als Sekretär am 27. Apr. 2012

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Rachel Elizabeth Fletcher als Sekretär am 27. Apr. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Paul Denzil John Sullivan als Direktor am 30. März 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter James Whitby als Geschäftsführer am 16. Feb. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    20 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mrs Sharon Jill Caterer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ian Merriman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    20 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Michael Merriman am 19. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Michael Merriman am 25. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Sekretär
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC269847
    169073830001
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Geschäftsführer
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360003
    SULLIVAN, Paul Denzil John
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish111421900001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Sekretär
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Sekretär
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Sekretär
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Sekretär
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WOODCOCK, Michael Ian Charles
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    British33177050001
    ASHWORTH, George Smith-Salmond
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish152638710001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROWNE, John Richard
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish133984130002
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish49141230004
    DOBBS, Clive Richard
    The Rowans Gravel Pits Close
    Bredon
    GL20 7QL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Rowans Gravel Pits Close
    Bredon
    GL20 7QL Tewkesbury
    Gloucestershire
    British44775400001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FINLAYSON, David John Mcintosh
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    British33124430005
    HALL, Phillip James
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    UkBritish106668160001
    HARDY, Thomas William
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    Geschäftsführer
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    EnglandBritish40359960002
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    British67501900002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrish100755360001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish85771600001
    MERRIMAN, Ian Michael
    Derrybawn
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Derrybawn
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Derrybawn
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Derrybawn
    Hampshire
    England
    EnglandBritish100771770002
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    POLLARD, John Reginald
    Frome Hall Frome Hall Lane
    GL5 3JH Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Frome Hall Frome Hall Lane
    GL5 3JH Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish31820530002
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Geschäftsführer
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004
    THORNTON, Jeffrey Michael
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    Geschäftsführer
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    United KingdomBritish19241770002
    WHITBY, Peter James
    Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Maple Tree House
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Maple Tree House
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish76096790002
    WHITTICK, Robert James
    35 Englewood Road
    SW12 9PA London
    Geschäftsführer
    35 Englewood Road
    SW12 9PA London
    British119328020001
    WOODCOCK, Michael Ian Charles
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    British33177050001

    Hat CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in and to the goods and articles of computer hardware and other goods pursuant to the master hpa. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 07. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgagor with full title guarantee has mortgaged to the mortgagee all its interest, present and future in and to the goods by way of first priority legal mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First priority mortgage
    Erstellt am 15. Juni 2001
    Geliefert am 29. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee pursuant to and/or under: a). To transfer and/or pass title, and to deliver, to the chargee any and all of the goods pursuant to and under clauses 10.3, 10.4, 14.2 and 15.1 of the master hpa (as the same are incorporated in the hp contract) and not to create,assume or permit to exist any security interest upon the goods other than pursuant to and/or under clause 12.2.3 of the master hpa (as the same is incorporated in the hp contract) and b). The mortgage
    Kurze Angaben
    By way of first priority legal mortgage all the company's interest present and future in and to the goods listed in appendix a of the hp contract.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 29. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 15. Juni 2001
    Geliefert am 29. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee pursuant to and/or under: (a) to transfer and/or pass title, and to deliver, to the chargee any and all of the goods pursuant to and/or under clauses 10.3, 10.4, 14.2 and 15.1 of the master hpa (as the same are incorporated in the hp contract) and not to create, assume or permit to exist any security interest upon the goods other than pursuant to and/or under clauses 12.2.3 of the master hpa (as the same is incorporated in the hp contract); and (b) the mortgage (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first priority legal mortgage all its interest, present and future in and to the goods provided that the chargee has acknowledged and agreed that the title to the goods the subject of the disposition by way of first priority legal mortgage shall be the same title recieved by the mortgagor on its purchase of the goods pursuant to the master hpa.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 29. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 2001
    Geliefert am 16. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master hire purchase agreement dated 28TH february 2001 between the mortgagor and mortgagee and the mortgage
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 16. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0