PREGIS INTERNATIONAL LTD
Überblick
| Unternehmensname | PREGIS INTERNATIONAL LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01200088 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PREGIS INTERNATIONAL LTD?
- Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Aspect One Gunnels Wood Road SG1 2DG Stevenage England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FP INTERNATIONAL (UK) LIMITED | 16. Sept. 2002 | 16. Sept. 2002 |
| FLO-PAK (U.K.) LIMITED | 13. Feb. 1975 | 13. Feb. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Cornelis Johannes Maria Oostrom als Geschäftsführer am 01. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Leon Poppegaai als Geschäftsführer am 01. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Leon Poppegaai als Direktor am 03. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 9 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Pregis Europe Limited as a person with significant control on 24. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Fpi Holding Company B.V. as a person with significant control on 01. Juni 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 13 Seiten | AA | ||
Notification of Pregis Europe Limited as a person with significant control on 01. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Victory House 400 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7PA zum Aspect One Gunnels Wood Road Stevenage SG1 2DG am 11. Mai 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 15 Seiten | AA | ||
legacy | 57 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUDHUIN, Kevin | Geschäftsführer | Lake Cook Road 60015 Deerfield 1650 Illinois United States | United States | American | 204740650001 | |||||
| LAVANWAY, Donald Keith | Geschäftsführer | Lake Cook Road 60015 Deerfield 1650 Illinois United States | United States | American | 204740660001 | |||||
| BLOOD, James | Sekretär | 605 Pisces Lane Foster City California Ca 94404 Usa | American | 69366890001 | ||||||
| GOODMAN, Stephen Tony | Sekretär | 4 Orchard Drive Off Royton Drive Whittle-Le-Woods PR7 1XJ Chorley Lancashire | British | 42598360002 | ||||||
| YOUNG, George Hunter | Sekretär | Penn 11 Plough Hill Cuffley EN6 4DN Potters Bar Hertfordshire | British | 9667110001 | ||||||
| BRIGHTMAN, Geoffrey William | Geschäftsführer | 38 Willow Drive Bourton Grange MK18 7JH Buckingham | British | 34946240001 | ||||||
| CAMPS, Rex | Geschäftsführer | c/o Sarah Higgins Pavilion Drive NN4 7PA Northampton 400 England | Netherlands | Dutch | 196700920001 | |||||
| CLARK, Michael | Geschäftsführer | Abbotts Wood Hill Road Penwortham PR1 9XH Preston Lancs | British | 3138650001 | ||||||
| CONNOR, Peter | Geschäftsführer | Carillon Bell Lane Syresham NN13 5HP Brackley Northamptonshire | British | 10181590001 | ||||||
| DAVIES, David William | Geschäftsführer | 77 Mably Grove OX12 9XW Wantage Oxfordshire | United Kingdom | British | 98272270001 | |||||
| FERNANDEZ, Dennis | Geschäftsführer | 19684 Ashton Court Saratoga Santa Clara Ca 95070 Usa | American | 69366850001 | ||||||
| GOODMAN, Stephen Tony | Geschäftsführer | 4 Orchard Drive Off Royton Drive Whittle-Le-Woods PR7 1XJ Chorley Lancashire | British | 42598360002 | ||||||
| GRAHAM, Arthur | Geschäftsführer | 700 Westridge Drive Portola Valley California Ca 94028 Usa | Usa | American | 69366730001 | |||||
| JACKSON, Steven | Geschäftsführer | c/o Sarah Higgins Pavilion Drive NN4 7PA Northampton 400 England | Usa | American | 196714870001 | |||||
| LANE, Gordon Stuart | Geschäftsführer | 6 Park Road High Barnet EN5 5SQ Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 551970006 | |||||
| MACFARLANE OF BEARSDEN, Lord | Geschäftsführer | 50 Manse Road Bearsden G61 3PN Glasgow Strathclyde Scotland | British | 51933510001 | ||||||
| MACKIE, William Paterson | Geschäftsführer | Clearwater 1 Queens Point Shandon G84 8QZ Helensburgh Dunbartonshire Scotland | British | 51933540001 | ||||||
| MARIA, Cornelis Johannes | Geschäftsführer | 6422 Pd Heerlen Heerlen Nijverheidsweg 4 Netherlands | Netherlands | Dutch | 255123480001 | |||||
| MATTHEWS, John Robert | Geschäftsführer | 14 Brick Kiln Close NN12 6TG Towcester Northamptonshire | British | 10181580001 | ||||||
| MOHENG, Jean Charles | Geschäftsführer | 5 Rue Henry Monnier FOREIGN Paris 75009 France | France | French | 113500440001 | |||||
| NEZWEK, Joe | Geschäftsführer | c/o Sarah Higgins Pavilion Drive NN4 7PA Northampton 400 England | United States | American | 196719920001 | |||||
| OOSTROM, Cornelis Johannes Maria | Geschäftsführer | 6422 Pd Heerlen Nijverheidsweg 4 Netherlands | Netherlands | Dutch | 255316200001 | |||||
| POPPEGAAI, Leon | Geschäftsführer | Walkern Road SG1 3QP Stevenage Richmond House Hertfordshire England | Netherlands | Dutch | 305565750001 | |||||
| VAN LEUSDEN, Casper Hubertus Antonius Titus | Geschäftsführer | 400 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7PA Northampton Victory House | Netherlands | Dutch | 227961200001 | |||||
| WALLACE, Richard Anthony | Geschäftsführer | 3 Wolverton Road Marston Green B37 7XJ Solihull West Midlands | England | British | 92603420001 | |||||
| YOUNG, George Hunter | Geschäftsführer | Penn 11 Plough Hill Cuffley EN6 4DN Potters Bar Hertfordshire | England | British | 9667110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PREGIS INTERNATIONAL LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pregis Limited | 01. Juni 2020 | Walkern Road SG1 3QP Stevenage Richmond House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Fpi Holding Company B.V. | 09. Mai 2016 | Nijverheidsweg 4 6422 Pd Heerlen Nijverheidsweg 4 Netherlands | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PREGIS INTERNATIONAL LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 2003 Geliefert am 01. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land adjoining buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 2003 Geliefert am 01. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land on the south side of buckingham road, brackley and the land and buildings on the west side of boundary road and on the south side of buckingham road, brackley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Okt. 2003 Geliefert am 01. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Apr. 2001 Geliefert am 19. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as land/blds on the west side of boundary road and on south side of buckingham rd,brackley,northamptonshire; t/nos HN12102 and HN11988. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0