FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFRANK PEARCE (TUGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01200967
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Tower Bridge House
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Endeavour House Crow Arch Lane Ringwood Hampshire BH24 1PN am 10. Juni 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Mai 2011

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Apr. 2011

    Kapitalaufstellung am 27. Apr. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Richard Johnson am 28. März 2011

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Murray John Easton als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Crawford als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Emma Campbell als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philip Morris als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Philip Hugh Morris am 11. Apr. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAMPBELL, Emma
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Sekretär
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    155111310001
    EASTON, Murray John
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Geschäftsführer
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritish62486170001
    JOHNSON, Mark Richard
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Geschäftsführer
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish61083530002
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    British78490580001
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    British78490580001
    MACINTOSH, Kenneth
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    Sekretär
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    British9297490001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    Sekretär
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    British34131020003
    MORRIS, Philip Hugh
    Crow Arch Lane
    BH24 1PN Ringwood
    Endeavour House
    Hampshire
    Sekretär
    Crow Arch Lane
    BH24 1PN Ringwood
    Endeavour House
    Hampshire
    British9233330003
    BEACH, Philip Graham
    Cobblestones Ducky Lane
    Landrake
    PL12 5DL Saltash
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Cobblestones Ducky Lane
    Landrake
    PL12 5DL Saltash
    Cornwall
    British9432480001
    CRAWFORD, Andrew
    Hawkswood 28 Branksome Hill Road
    BH4 9LD Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    Hawkswood 28 Branksome Hill Road
    BH4 9LD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish17276890001
    DYBALL, Adrian Stuart Brennan
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    Geschäftsführer
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    British58499000002
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish78490580001
    HIRST, Martin Beverley Bodenham
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish9289310002
    MCNAUGHTON, Andrew James
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    British101231740001
    PEASLAND, Michael John
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    Geschäftsführer
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    United KingdomBritish714450006
    WHITE, Brian Alexander
    57 Carrington Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RA Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    57 Carrington Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RA Lymington
    Hampshire
    British9432490001

    Hat FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of covenants
    Erstellt am 10. Dez. 1986
    Geliefert am 30. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current secured by a charge dated 10.12.86
    Kurze Angaben
    All policies of insurance and all benefits thereof all freight hires & any other monies earned and due to the owner.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Ships mortgage
    Erstellt am 10. Dez. 1986
    Geliefert am 30. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a deed of covenants dated 10.12.86
    Kurze Angaben
    64/64 shares of mv/FP17 london no 97 in 1986 and official no 388447.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenant
    Erstellt am 04. Juni 1986
    Geliefert am 23. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on an account current secured by a charge dated 4-6-86
    Kurze Angaben
    (1) all policies & contracts of insurance now or hereafter taken out in respect of the ship, ler freights profits or other wise & all the benefits thereof (2) all freights lines & any other moneys earned & to be earned for the account of the borrower (3) all moneys & claims for money due and to become due to the owner in respect of any requisition of title to or use of the ship (see doc M21).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    Ships morgage
    Erstellt am 04. Juni 1986
    Geliefert am 23. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenants dated 4-6-8
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty-fourth shares of the fpt iv of rochester no 11 of 1974 official no:- 338718.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of covenants
    Erstellt am 10. Jan. 1986
    Geliefert am 22. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee account current secured by a mortgage
    Kurze Angaben
    All policies contracts of insurance (inc war risks) in respect of the ship for frights disbursements, profits or otherwise inc. Claims & return of premiums. All frights hires & other moneys earned out or to become due in respect of any breach in charter party or contract of affreightment all moneys & claims for money due in respect of any requisition title to or use of the ship (see M19).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Ships mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 1986
    Geliefert am 22. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a deed of covenants dated 10/1/86
    Kurze Angaben
    64TH shares of mv fptiv of rochester NO11 of 1974 & official no 338718 (the ship).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Jan. 1986
    Geliefert am 20. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book & other debts now & from time to time hereafter due owing. Floating charge on (see M18). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of coenant
    Erstellt am 27. März 1981
    Geliefert am 06. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversecured by a mortgage dated 27THMARCH,1981
    Kurze Angaben
    All policies and contracts of insurance (inc. War risks) in respect of the ship, for freights, disbursements, profits or otherwise including claims and return of premises all freights hires and other moneys earned out of the ships operation and all moneys due or to become due in respect of any breach in charter party or contract of affreightment all money and claims for monry due in respect of any registration of title to or use of the ship (please see doc M17).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    Ships morgage
    Erstellt am 27. März 1981
    Geliefert am 06. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current dated the terms of a deed of covenant dated 27TH march 1981
    Kurze Angaben
    64/64 shares of mv fpt ii of poole no 25M 1978 and official no. 378200 (the ship).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 27. März 1981
    Geliefert am 06. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversecured by a mortgage dated 27TH march,1981
    Kurze Angaben
    All fixtures and contracts of insurance (inc war risks) in respect of the ship, per freights and disbursements, profits or otherwise including claims and return of premises all freights hires and other monies out of the ships operation and all monies due or to become due in respect of any breach in charter party or contract of affreightment all money and claims for money due in respect of any requisition of title to or use of the ship (please see doc M16).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    Ships mortgage
    Erstellt am 27. März 1981
    Geliefert am 06. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a deed of covenent dated 27 march 1981
    Kurze Angaben
    64/64 shares of mv.FPT1 of poole no.16 In 1978 and official no 378199 (the ship).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 15. Okt. 1980
    Geliefert am 29. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current secured by a charge dated 15/10/80
    Kurze Angaben
    All policies & contracts of insurance taken out in respect of the ship, for freights, disbursements, profits & all claims benefits. All monies earned out of the ship's operations. See doc M15B.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1980Registrierung einer Belastung
    Ship's mortgage
    Erstellt am 15. Okt. 1980
    Geliefert am 29. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a deed of covenant dated 15/10/80
    Kurze Angaben
    64/64 the shares of mv pullwell delta of poole no.69 In 1980. official n O. 303828.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat FRANK PEARCE (TUGS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Mai 2011Beginn der Liquidation
    11. Jan. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp
    Tower Bridge House
    E1W 1DD St Katharine'S Way
    London
    Praktiker
    Mazars Llp
    Tower Bridge House
    E1W 1DD St Katharine'S Way
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0