THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED

THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01201607
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o VANTIS
    66 Wigmore Street
    2653
    W1A 3RT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE BUTTON GROUP LIMITED09. Apr. 199009. Apr. 1990
    BUTTON DESIGN CONTRACTS LIMITED 26. Feb. 197526. Feb. 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Nile House Nile Street Brighton East Sussex BN1 1HW am 01. Feb. 2010

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Mcowat als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Futuremedia Plc am 18. Dez. 2009

    1 SeitenCH02

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    2 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    2 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    10 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FUTUREMEDIA PLC
    c/o Marlor Walls
    Marquis Court
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0RU Gateshead
    C12
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Marlor Walls
    Marquis Court
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0RU Gateshead
    C12
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    38469650002
    JOSEPH, Anne Janette
    68 Hillway
    N6 6DP London
    Sekretär
    68 Hillway
    N6 6DP London
    British60285460001
    MACHIN, Peter Graham
    12 Nineveh Shipyard
    BN18 9SU Arundel
    West Sussex
    Sekretär
    12 Nineveh Shipyard
    BN18 9SU Arundel
    West Sussex
    British63945030001
    MCINTYRE, John Francis
    Flat 1
    7 Mulgrave Road
    CR0 1BL Croydon
    Sekretär
    Flat 1
    7 Mulgrave Road
    CR0 1BL Croydon
    British3843730003
    MCOWAT, Elizabeth
    Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Sekretär
    Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    British126382290001
    RAJARATNAM, Narishta
    14 Queen Elizabeth Drive
    N14 6RD London
    Sekretär
    14 Queen Elizabeth Drive
    N14 6RD London
    British125077050001
    TORDJMAN-KULCZAK, Sylvie
    47 Islingword Street
    BN2 9US Brighton
    Sekretär
    47 Islingword Street
    BN2 9US Brighton
    French123099510001
    WILSON, Arthur Dominic
    11 Christchurch Road
    N8 9QL London
    Sekretär
    11 Christchurch Road
    N8 9QL London
    British12836660001
    BINGHAM, Robert Edward
    25 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    Geschäftsführer
    25 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    United KingdomBritish103499540001
    BINGHAM, Susan Mary
    25 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    Geschäftsführer
    25 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    EnglandBritish114337600001
    BINGHAM, Thomas
    11 Whitstone Lane
    BR3 3GY Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    11 Whitstone Lane
    BR3 3GY Beckenham
    Kent
    British84072010002
    FERTIG, Leonard Martin
    8 Montpelier Villas
    BN1 3DH Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    8 Montpelier Villas
    BN1 3DH Brighton
    East Sussex
    EnglandUnited States68560490004
    FORSTER, Peter Nicholas
    58 Elmwood Road
    Chiswick
    W4 3DZ London
    Geschäftsführer
    58 Elmwood Road
    Chiswick
    W4 3DZ London
    United KingdomBritish14073160001
    GREETHAM, Keith Paul
    The Flower Knott
    Cutthroat Crossroads
    B94 6BL Earlswood
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Flower Knott
    Cutthroat Crossroads
    B94 6BL Earlswood
    Warwickshire
    British15303600001
    MCINTYRE, John Francis
    Flat 1
    7 Mulgrave Road
    CR0 1BL Croydon
    Geschäftsführer
    Flat 1
    7 Mulgrave Road
    CR0 1BL Croydon
    United KingdomBritish3843730003
    PALMER, David
    Orchard House
    Colebach
    LE17 4HT Lutterworth
    Leicester
    Geschäftsführer
    Orchard House
    Colebach
    LE17 4HT Lutterworth
    Leicester
    British15303620001
    ROBINSON, Christopher Anders
    22 Stanhope Road
    Highgate
    N6 5NG London
    Geschäftsführer
    22 Stanhope Road
    Highgate
    N6 5NG London
    British58022160001
    RUSBRIDGE, Michael John
    Hillside 18 Broad Highway
    KT11 2RP Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hillside 18 Broad Highway
    KT11 2RP Cobham
    Surrey
    British6361530001
    WILSON, Arthur Dominic
    11 Christchurch Road
    N8 9QL London
    Geschäftsführer
    11 Christchurch Road
    N8 9QL London
    EnglandBritish12836660001

    Hat THE BUTTON COMMUNICATIONS GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Apr. 1999
    Geliefert am 27. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Mai 1998
    Geliefert am 20. Mai 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or eventures international limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 07. Jan. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Letter of charge
    Erstellt am 18. Feb. 1981
    Geliefert am 05. März 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £10,000 from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H property 61, shelton street, london, WC2.
    Berechtigte Personen
    • Michael D. Page Esq.
    Transaktionen
    • 05. März 1981Registrierung einer Belastung
    • 07. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Juli 1979
    Geliefert am 01. Aug. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or button design unit limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1979Registrierung einer Belastung
    • 07. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of indemnity
    Erstellt am 28. Juli 1977
    Geliefert am 17. Aug. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies which the chargee may be called upon to pay under the terms of a guarantee, 28-7-77 not exceeding £10,000.
    Kurze Angaben
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Michael Dudley Page
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1977Registrierung einer Belastung
    • 07. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0