PIPEX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PIPEX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01203356 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIPEX LIMITED?
- Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich PIPEX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Stonedale Road Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Gloucestershire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIPEX LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PIPEX LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juli 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Aug. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juli 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIPEX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2025 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 28 Seiten | MA | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Nov. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 34 Seiten | AA | ||||||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Martin John Quilter zum Sekretär | 5 Seiten | RP04AP03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Martin John Quilter als Sekretär am 10. Juni 2024 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison May Sloan als Sekretär am 17. Mai 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Paul O'neil am 13. Feb. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. Dez. 2022 | 35 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ian Broughton als Direktor am 30. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robbert Oudendijk als Geschäftsführer am 30. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 37 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 37 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O National Oilwell Varco Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ United Kingdom zum Stonedale Road Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ am 20. Juli 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Change of details for National Oilwell Varco Uk Limited as a person with significant control on 11. Juni 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PIPEX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUILTER, Martin John | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco United Kingdom | 323915730001 | |||||||||||
| BROUGHTON, Ian | Geschäftsführer | Badentoy Crescent Badentoy Industrial Park AB12 4YD Portlethen C/O National Oilwell Varco Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 307428290001 | |||||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 162062160002 | |||||||||
| MURPHY, William Joseph | Sekretär | 1 Belliver Way PL6 7BP Plymouth Pipex House Devon Enterprise Facility | British | 99265470001 | ||||||||||
| SLOAN, Alison May | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 203827310001 | |||||||||||
| SMITH, Alan William Bedford | Sekretär | Smiths Wood Cottage Sigford TQ12 6LE Newton Abbot Devon | British | 17572740002 | ||||||||||
| THOMAS, Valerie Gladys | Sekretär | 144 Commonwealth Road CR3 6LS Caterham Surrey | British | 17572730001 | ||||||||||
| WRIGHT, Steven | Sekretär | 38 Fairfield Sampford Peverell EX16 7DE Tiverton Devon | British | 61971200001 | ||||||||||
| CURZON CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Grenadier Road EX1 3LH Exeter Ashford House Devon United Kingdom |
| 65608250008 | ||||||||||
| MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House United Kingdom |
| 107218000001 | ||||||||||
| PIPEX LIMITED | Sekretär | Devon Enterprise Facility 1 Belliver Way Roborough PL6 7BP Plymouth Pipex House Devon United Kingdom |
| 153424280001 | ||||||||||
| BARR, Jon | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 183517000001 | |||||||||
| BROWN, Christopher Meredith | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | Scotland | British | 165835640001 | |||||||||
| BYRNE, Thomas Paul | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 109463760001 | |||||||||
| EADE, Donald Keith | Geschäftsführer | Kilve Park Copse RH5 4BL Dorking Surrey | British | 2859780001 | ||||||||||
| EVES, Simon | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | Scotland | British | 99574020001 | |||||||||
| FLEMING, Alastair James | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||||||
| HEWSTONE, Matthew John | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 108288160001 | |||||||||
| INCE, Jeffrey Steven | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 194238550001 | |||||||||
| KENNETT, Adrian Peter | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 76174650001 | |||||||||
| LIGHTFOOT, Andrew David | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 186790070001 | |||||||||
| MORRIS, Peter John | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 183517680001 | |||||||||
| MURPHY, William Joseph | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | England | British | 99265470001 | |||||||||
| OUDENDIJK, Robbert | Geschäftsführer | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||||||
| RAYNOR, Sarah Jane | Geschäftsführer | 1 Belliver Way PL6 7BP Plymouth Pipex House Devon Enterprise Facility | United Kingdom | British | 134075280002 | |||||||||
| REID, Simon Scott | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||||||
| RIDGEWELL, Derek Gordon | Geschäftsführer | New Hay Farm Brenchley TN12 7DG Tonbridge Kent | British | 17572750001 | ||||||||||
| SMITH, Alan William Bedford | Geschäftsführer | 1 Belliver Way PL6 7BP Plymouth Pipex House Devon Enterprise Facility | England | British | 17572740002 | |||||||||
| SMITH, Timothy Alan Bedford | Geschäftsführer | Yarde Down Silverton EX45 4DG Exeter South Barn Devon | United Kingdom | British | 271454710001 | |||||||||
| SMITH, Tom Henry Bedford | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 108224760001 | |||||||||
| STAIT, Geraint Wynn | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 138600240001 | |||||||||
| WRIGHT, Steven | Geschäftsführer | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | England | British | 61971200001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIPEX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Oilwell Varco Uk Limited | 12. Feb. 2021 | Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Pipex Px Ltd | 06. Apr. 2016 | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PIPEX LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 21. Juli 2016 | 21. Juli 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0