BLISS REFRIGERATION LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BLISS REFRIGERATION LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01205305 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLISS REFRIGERATION LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich BLISS REFRIGERATION LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o MRS E WHITEHOUSE Dolphin House Moreton Business Park Moreton-On-Lugg HR4 8DS Hereford |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLISS REFRIGERATION LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ICG (UK) LIMITED | 05. Sept. 1997 | 05. Sept. 1997 |
SUTER ENVIRONMENTAL LIMITED | 27. Juli 1983 | 27. Juli 1983 |
SEARLE MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 27. März 1975 | 27. März 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLISS REFRIGERATION LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLISS REFRIGERATION LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mark Collins Dolphin House Moreton Business Park Moreton-on-Lugg Hereford HR4 8DS zum C/O Mrs E Whitehouse Dolphin House Moreton Business Park Moreton-on-Lugg Hereford HR4 8DS am 18. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Stephenson als Geschäftsführer am 19. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Neil Stephenson 20 Davis Way Newgate Lane Fareham Hampshire PO14 1AR United Kingdom am 30. Apr. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Pritchard als Direktor am 30. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard James Saunders als Direktor am 19. März 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von George Robert Vance als Geschäftsführer am 30. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Robert Gillett als Geschäftsführer am 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BLISS REFRIGERATION LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITCHARD, David James | Geschäftsführer | c/o Mrs E Whitehouse Moreton Business Park Moreton-On-Lugg HR4 8DS Hereford Dolphin House England | England | English | Director | 107686340002 | ||||
SAUNDERS, Richard James | Geschäftsführer | c/o Mrs E Whitehouse Moreton Business Park Moreton-On-Lugg HR4 8DS Hereford Dolphin House England | United Kingdom | British | Director | 167892490001 | ||||
GIVEN, Janet Mary | Sekretär | 11 Little Riding Oriental Road GU22 7EP Woking Surrey | British | 92871140001 | ||||||
HURST, Dennis Grahame | Sekretär | 26 Privett Road Alverstoke PO12 3SU Gosport Hampshire | British | 11461950001 | ||||||
MEYERS, Richard John | Sekretär | 84 Hemingford Road Islington N1 1DD London | British | 71241210001 | ||||||
PEARCE, Christopher John | Sekretär | 36 Cheriton Road SO22 5AY Winchester Hampshire | British | Company Secretary/Director | 101239800001 | |||||
RACE, Geoffrey Robin | Sekretär | 1 Oakland Road NE2 3DR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Secretary/Director | 66197630001 | |||||
ROBERTS, Christopher John | Sekretär | 45 Brooklynn Close Waltham Chase SO32 2RZ Southampton | British | Finance Director | 39163120001 | |||||
WILLIAMS, John Benedict Alan | Sekretär | 16 Oakwood Road Golders Green NW11 6QY London | British | 79419360001 | ||||||
ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED | Sekretär | 2 Heathrow Boulevard 284 Bath Road UB7 0DQ West Drayton Middlesex | 67372750003 | |||||||
ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Heathrow Boulevard 284 Bath Road UB7 0DQ West Drayton Middlesex | 69324550001 | |||||||
EDWARDS, John Nigel | Geschäftsführer | 8b Avery Row Mayfair W1K 4AL London | United Kingdom | British | Accountant | 37742270003 | ||||
FINKEMEYER, Geoffrey Colin | Geschäftsführer | Diamond House Lotus Park Kingsbury Cresecent TW18 3AG Staines Middlesex | Australian | Vice President | 34631110007 | |||||
FOLGER, Susan | Geschäftsführer | 12 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | British | Chartered Secretary | 36525980001 | |||||
GILLETT, David Robert | Geschäftsführer | 37 Kings Copse Road SO30 0PQ Southampton Hampshire | England | British | Company Director | 87290920001 | ||||
GILLETT, David Robert | Geschäftsführer | 37 Kings Copse Road SO30 0PQ Southampton Hampshire | England | British | Company Director | 87290920001 | ||||
GRANT, John Albert Martin | Geschäftsführer | The Malthouse Manor Lane Claverdon CV35 8NH Warwick Warwickshire | England | British | Chief Executive | 55161940001 | ||||
HENSON, Mark Richard | Geschäftsführer | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 104630800001 | ||||
HEWITT, Alan | Geschäftsführer | The White House Casthorpe Road Barrowby NG32 1DW Grantham Lincolnshire | British | Company Director | 572100002 | |||||
HURST, Dennis Grahame | Geschäftsführer | 26 Privett Road Alverstoke PO12 3SU Gosport Hampshire | British | Finance Director | 11461950001 | |||||
LANTINGA, Theodorus Franciscus Hermanus | Geschäftsführer | c/o Neil Stephenson Davis Way Newgate Lane PO14 1AR Fareham 20 Hampshire United Kingdom | Netherlands | Dutch | Business Development Manager | 133736230001 | ||||
LITTLE, James Sefton | Geschäftsführer | Langdons Swelling Hill Ropley SO24 0DA Alresford Hampshire | British | Company Director | 32198060001 | |||||
OWEN, Anthony Gordon Vivian | Geschäftsführer | 33 The Avenue Alverstoke PO12 2JS Gosport Hampshire | England | British | Company Director | 572090001 | ||||
PEARCE, Christopher John | Geschäftsführer | 36 Cheriton Road SO22 5AY Winchester Hampshire | England | British | Managing Director | 101239800001 | ||||
RACE, Geoffrey Robin | Geschäftsführer | 1 Oakland Road NE2 3DR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Secretary/Director | 66197630001 | |||||
RIJKOORT, Petrus Antonius | Geschäftsführer | Pippeling 17 Nl-2271 Ph Boskoop Netherlands | Dutch | Vice President | 133737330001 | |||||
RILEY, Denys John | Geschäftsführer | The Haven Redlands Lane PO10 7SN Emsworth Hampshire | British | Company Director | 32198050001 | |||||
ROBERTS, Christopher John | Geschäftsführer | 45 Brooklynn Close Waltham Chase SO32 2RZ Southampton | British | Finance Director | 39163120001 | |||||
SAUNDERS, Richard James | Geschäftsführer | 21 Riverside Way WR9 8UP Droitwich Worcestershire | British | Manufacturing Director | 62136130001 | |||||
SCHUBERT, Leonard Roy | Geschäftsführer | 9 Brecon View BS24 9NF Weston Super Mare Somerset | British | Company Director | 82083510001 | |||||
SMITH, Geoffrey Reginald | Geschäftsführer | 1 Coach Hill Titchfield PO14 4EE Fareham Hampshire | British | Company Director | 13432990001 | |||||
STEPHENSON, Neil | Geschäftsführer | The Knapp Hewshott Lane GU30 7SS Liphook Hampshire | England | British | Accountant | 58926230005 | ||||
VANCE, George Robert | Geschäftsführer | High Willows Brentsbrook Park North Holmwood RH5 4JL Dorking Surrey | England | British | Director | 32945610001 | ||||
VINCENT, Michael | Geschäftsführer | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | Finance Director | 99258270001 | ||||
WALLBANKS, Robert | Geschäftsführer | 31 Osborne View Road Hill Head PO14 3JW Fareham Hampshire | British | Sales & Marketing Director | 32198070001 |
Hat BLISS REFRIGERATION LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 16. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as icg (UK) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Searle maunfacturing company limited 380,000 ordinary shares of £1 and 1,000 preferred ordinary shares of £1 each buildtape limited 2 ordinary shares of £1 each ss coils limited 886,000 ordinary shares of £1 each. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 16. Juli 2002 Geliefert am 24. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission | Erstellt am 23. März 1995 Geliefert am 10. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus debenture | Erstellt am 25. Mai 1994 Geliefert am 01. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1982 Geliefert am 18. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under any recourse agreement | |
Kurze Angaben All f/h & l/h and other property of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1982 Geliefert am 05. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital, book & other debts, stock & shares and other securities all buildings fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 21. Mai 1981 Geliefert am 28. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or fixture account of the company with lloyds bank limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Special omnibus letter of setoff dated | Erstellt am 30. Juni 1980 Geliefert am 08. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0