TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01212935 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 City Place Beehive Ring Road RH6 0HA Gatwick Airport West Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DARLINGTON CHARTER FREIGHT SERVICES LIMITED | 16. Mai 1975 | 16. Mai 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Plant Nominees Limited am 11. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Plant Nominees Limited am 11. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Grayston Central Services Limited am 11. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2013
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Sept. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kenneth Johnson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Petar Cvetkovic als Geschäftsführer am 30. Aug. 2009 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Plant Nominees Limited als Direktor am 29. Nov. 2011 | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alexandra Jane Laan als Sekretär am 29. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Griffiths als Geschäftsführer am 29. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Grayston Central Services Limited als Direktor am 22. Aug. 2011 | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANT NOMINEES LIMITED | Sekretär | Meadows Business Park Blackwater GU17 9AB Camberley Riverbank Surrey England |
| 162779680001 | ||||||||||
| LAAN, Alexandra Jane | Geschäftsführer | City Place Beehive Ring Road RH6 0HA Gatwick Airport 2 West Sussex England | United Kingdom | British | 89963780002 | |||||||||
| GRAYSTON CENTRAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Meadows Business Park Blackwater GU17 9AB Camberley Riverbank Surrey England |
| 163144170001 | ||||||||||
| PLANT NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Meadows Business Park Blackwater GU17 9AB Camberley Riverbank Surrey England |
| 165159470001 | ||||||||||
| BROWN, Gareth Trevor | Sekretär | 19 Holbrook School Lane RH12 5PP Horsham West Sussex | British | 15885460002 | ||||||||||
| COTTERILL, Mark Bernard | Sekretär | 20 Buxton Old Road SK11 7EL Macclesfield Cheshire | British | 9541300002 | ||||||||||
| JOHNSON, Kenneth | Sekretär | Target Express House Woodlands Park Ashton Road WA12 0HF Newton Le Willows Merseyside | British | 56853980002 | ||||||||||
| LAAN, Alexandra Jane | Sekretär | Hartington Close Reigate Hill RH2 9NL Reigate 14 Surrey | British | 89963780002 | ||||||||||
| MITCHELL, James Keith | Sekretär | Castle Cob Kingswood WA6 6JJ Warrington Cheshire | British | 44040160001 | ||||||||||
| BROOM, Keith | Geschäftsführer | Target Express House Woodlands Park Ashton Road WA12 0HF Newton Le Willows Merseyside | British | 42112330008 | ||||||||||
| COOKE, Michael Andrew | Geschäftsführer | Somerley Middle Drive TN22 2HG Maresfield Park East Sussex | British | 58733830001 | ||||||||||
| COTTERILL, Mark Bernard | Geschäftsführer | 20 Buxton Old Road SK11 7EL Macclesfield Cheshire | England | British | 9541300002 | |||||||||
| CVETKOVIC, Petar | Geschäftsführer | Target Express House Woodlands Park, Ashton Road WA12 0HF Newton Le Willows | British | 59602020005 | ||||||||||
| CVETKOVIK, Petar | Geschäftsführer | Brookledge Lane SK10 4JU Adlington Highlands Cheshire | British | 129068030001 | ||||||||||
| GODMAN, Stuart | Geschäftsführer | Appletree Road OX17 1LW Chipping Warden 18 Oxfordshire | Uk | British | 132540700001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Paul | Geschäftsführer | City Place Beehive Ring Road RH6 0HA Gatwick Airport 2 West Sussex England | England | British | 11329830003 | |||||||||
| GRIFFITHS, Raymond Gordon | Geschäftsführer | 248 Burnley Road Weir OL13 8QR Bacup Lancashire | British | 5115700001 | ||||||||||
| HARRISON, Michael Glyn | Geschäftsführer | Flat 1 70 Tottenham Road N1 4ER London | British | 110257110001 | ||||||||||
| JENKINS, Brian Michael | Geschäftsführer | Oakenshaw House Oakenshaw View, Whitworth OL12 8SP Rochdale | British | 56957130004 | ||||||||||
| JOHNSON, Kenneth | Geschäftsführer | 29 Patch Croft Road Peel Hall Wythenshawe M22 5JR Manchester | British | 56853980001 | ||||||||||
| KENYON, Martin | Geschäftsführer | 44 Townscliffe Lane Marple Bridge SK6 5AP Stockport Cheshire | England | United Kingdom | 58648840001 | |||||||||
| MITCHELL, James Keith | Geschäftsführer | Castle Cob Kingswood WA6 6JJ Warrington Cheshire | British | 44040160001 | ||||||||||
| MURRAY, Paul | Geschäftsführer | High Point Tirley Lane Utkinton CW6 0JZ Tarporley Cheshire | British | 56957060002 | ||||||||||
| NEUMARK, Peter Stephen | Geschäftsführer | Netherdale Carriage Drive Frodsham WA6 6EB Warrington Cheshire | British | 78079880001 | ||||||||||
| SHARP, Iain George | Geschäftsführer | Glan Yr Afon Hall Llanferres CH7 5SB Mold Clwyd | British | 53447160001 | ||||||||||
| TYLER, Colin James | Geschäftsführer | 7 Green Park HP16 0PZ Prestwood Buckinghamshire | England | British | 53150030001 | |||||||||
| WILSON, David John | Geschäftsführer | 4 Eldon Avenue Shirley CR0 8SD Croydon Surrey | British | 110257220001 |
Hat TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 05. Sept. 2006 Geliefert am 15. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h premises k/a land at merrivale road okehampton devon (also k/a land at exeter road industrial estate okehampton devon) t/n DN412848. The l/h premises k/a barley castle trading estate barley castle lane appleton warrington cheshire t/n CH340963 (also k/a land lying to the south-east of lyncastle road appleton) the l/h premises k/a 22 eastbury road the london industrial park beckton london t/n EGL300427. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between target express holdings limited, target express limited, target express parcels limited, target international logistics limited and mizuho corporate bank LTD., As security agent for itself and each of the secured parties | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between target express holdings limited,target express limited,target express parcels limited,target international logistics limited (and each company which becomes a party to the debenture by executing a deed of accession) and the fuji bank,limited as agent and trustee for itself and each of the lenders | Erstellt am 18. Feb. 2000 Geliefert am 03. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between target international logistics limited, target express parcels limited and broomco (1437) limited (together the chargors) and the fuji bank limited as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (the security agent) | Erstellt am 02. Feb. 1998 Geliefert am 11. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 03. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit B356 hornvale avenue, aycliffe industrial estate, newton aycliffe, sedge field, county durham. Title nos du 129787 and du 137150. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1986 Geliefert am 21. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See doc ma). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0