TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED

TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01212935
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    West Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DARLINGTON CHARTER FREIGHT SERVICES LIMITED16. Mai 197516. Mai 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Änderung der Details des Sekretärs für Plant Nominees Limited am 11. Aug. 2014

    1 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Plant Nominees Limited am 11. Aug. 2014

    1 SeitenCH02

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Grayston Central Services Limited am 11. Aug. 2014

    1 SeitenCH02

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Kapitalaufstellung am 11. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kenneth Johnson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Petar Cvetkovic als Geschäftsführer am 30. Aug. 2009

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Plant Nominees Limited als Direktor am 29. Nov. 2011

    3 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Alexandra Jane Laan als Sekretär am 29. Nov. 2011

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Griffiths als Geschäftsführer am 29. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Grayston Central Services Limited als Direktor am 22. Aug. 2011

    3 SeitenAP02

    Wer sind die Geschäftsführer von TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Sekretär
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1045604
    162779680001
    LAAN, Alexandra Jane
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    United KingdomBritish89963780002
    GRAYSTON CENTRAL SERVICES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer906194
    163144170001
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1045604
    165159470001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    British15885460002
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    British9541300002
    JOHNSON, Kenneth
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Sekretär
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    British56853980002
    LAAN, Alexandra Jane
    Hartington Close
    Reigate Hill
    RH2 9NL Reigate
    14
    Surrey
    Sekretär
    Hartington Close
    Reigate Hill
    RH2 9NL Reigate
    14
    Surrey
    British89963780002
    MITCHELL, James Keith
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    British44040160001
    BROOM, Keith
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    British42112330008
    COOKE, Michael Andrew
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    British58733830001
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish9541300002
    CVETKOVIC, Petar
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Geschäftsführer
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    British59602020005
    CVETKOVIK, Petar
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    British129068030001
    GODMAN, Stuart
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    UkBritish132540700001
    GRIFFITHS, Paul
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    EnglandBritish11329830003
    GRIFFITHS, Raymond Gordon
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    Geschäftsführer
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    British5115700001
    HARRISON, Michael Glyn
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    British110257110001
    JENKINS, Brian Michael
    Oakenshaw House
    Oakenshaw View, Whitworth
    OL12 8SP Rochdale
    Geschäftsführer
    Oakenshaw House
    Oakenshaw View, Whitworth
    OL12 8SP Rochdale
    British56957130004
    JOHNSON, Kenneth
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    Geschäftsführer
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    British56853980001
    KENYON, Martin
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    EnglandUnited Kingdom58648840001
    MITCHELL, James Keith
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Castle Cob
    Kingswood
    WA6 6JJ Warrington
    Cheshire
    British44040160001
    MURRAY, Paul
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    British56957060002
    NEUMARK, Peter Stephen
    Netherdale Carriage Drive
    Frodsham
    WA6 6EB Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Netherdale Carriage Drive
    Frodsham
    WA6 6EB Warrington
    Cheshire
    British78079880001
    SHARP, Iain George
    Glan Yr Afon Hall
    Llanferres
    CH7 5SB Mold
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Glan Yr Afon Hall
    Llanferres
    CH7 5SB Mold
    Clwyd
    British53447160001
    TYLER, Colin James
    7 Green Park
    HP16 0PZ Prestwood
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Green Park
    HP16 0PZ Prestwood
    Buckinghamshire
    EnglandBritish53150030001
    WILSON, David John
    4 Eldon Avenue
    Shirley
    CR0 8SD Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Eldon Avenue
    Shirley
    CR0 8SD Croydon
    Surrey
    British110257220001

    Hat TARGET INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 05. Sept. 2006
    Geliefert am 15. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a land at merrivale road okehampton devon (also k/a land at exeter road industrial estate okehampton devon) t/n DN412848. The l/h premises k/a barley castle trading estate barley castle lane appleton warrington cheshire t/n CH340963 (also k/a land lying to the south-east of lyncastle road appleton) the l/h premises k/a 22 eastbury road the london industrial park beckton london t/n EGL300427. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture between target express holdings limited, target express limited, target express parcels limited, target international logistics limited and mizuho corporate bank LTD., As security agent for itself and each of the secured parties
    Erstellt am 11. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mizuho Corporate Bank LTD., as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between target express holdings limited,target express limited,target express parcels limited,target international logistics limited (and each company which becomes a party to the debenture by executing a deed of accession) and the fuji bank,limited as agent and trustee for itself and each of the lenders
    Erstellt am 18. Feb. 2000
    Geliefert am 03. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Fuji Bank,Limited
    Transaktionen
    • 03. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between target international logistics limited, target express parcels limited and broomco (1437) limited (together the chargors) and the fuji bank limited as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (the security agent)
    Erstellt am 02. Feb. 1998
    Geliefert am 11. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Fuji Bank Limited
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Sept. 1989
    Geliefert am 03. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit B356 hornvale avenue, aycliffe industrial estate, newton aycliffe, sedge field, county durham. Title nos du 129787 and du 137150.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 07. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1986
    Geliefert am 21. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See doc ma). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1986Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0