SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED

SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUTURAL (PROPERTIES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01216559
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cala House
    54 The Causeway
    TW18 3AX Staines
    Surrey
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2015

    3 Seiten4.68

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2013

    7 Seiten4.68

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Block B Burgan House the Causeway Staines TW18 3PA* am 02. März 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 210,000
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    BROWN, Alan Duke
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    Geschäftsführer
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    EnglandBritish32640750005
    MILLAR, Robert James
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    British3211980006
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54537790003
    LAYTONS SOLICITORS
    Tempus Court
    Onslow Street
    GU1 4SS Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Tempus Court
    Onslow Street
    GU1 4SS Guildford
    Surrey
    10280530002
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    ALLAN, John
    4 Church Hams
    Finchampstead
    RG40 4XF Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Church Hams
    Finchampstead
    RG40 4XF Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish91693130001
    BALL, Geoffrey Arthur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish246030002
    BOYLE, Gerard Peter
    Bowmans Popham Lane
    North Waltham
    RG25 2BE Basingstoke
    Hants
    Geschäftsführer
    Bowmans Popham Lane
    North Waltham
    RG25 2BE Basingstoke
    Hants
    British28031080001
    BROWN, Alan Duke
    CV37
    Geschäftsführer
    CV37
    EnglandBritish32640750005
    DATE, Roger Gareth
    Marshbrook
    12 Mallards Way
    GU18 5ND Lightwater
    Surrey
    Geschäftsführer
    Marshbrook
    12 Mallards Way
    GU18 5ND Lightwater
    Surrey
    British21362540001
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    MOORE, Alan Sutherland
    7 Chatsworth Drive
    SP10 3UF Andover
    Hampshire
    Geschäftsführer
    7 Chatsworth Drive
    SP10 3UF Andover
    Hampshire
    British35539850001
    WILKINSON, Colin
    31 Batts Park
    TA1 4RE Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    31 Batts Park
    TA1 4RE Taunton
    Somerset
    British34534080001

    Hat SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 07. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC ( the “Security Trustee”)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 21. Dez. 2009
    Geliefert am 23. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital) from time to time (the charged assets).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2009
    Geliefert am 23. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including uncalled capital, buildings and fixtures, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Letter of offset
    Erstellt am 09. Aug. 1989
    Geliefert am 11. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of the company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1988
    Geliefert am 01. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at the near of 121 nine mile ride, wokingham and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Nov. 1988
    Geliefert am 25. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    119 nine mile ride wokingham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First legal charge
    Erstellt am 10. Aug. 1988
    Geliefert am 18. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    123, nine mile ride, wokingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. März 1988
    Geliefert am 21. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the north of nine mile ride, wokingham, title no:- bk 245827.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company, Barkers
    Transaktionen
    • 21. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. März 1988
    Geliefert am 21. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the north of nine mile ride, wokingham, title no:- bk 254038. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company, Barkers
    Transaktionen
    • 21. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1986
    Geliefert am 24. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at deerhurst manor park, nine mile ride, wokingham, berkshire, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company.
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Feb. 1984
    Geliefert am 16. Feb. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at imperial rd bayleys lane fulham london tn ngl 471954 &/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1984Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Nov. 1983
    Geliefert am 14. Dez. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying on the south side of st john's crescent broadbridge heath, west sussex title no's wsx 71279 and wsx 73190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1983Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Juli 1983
    Geliefert am 01. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    119 nine mile ride wokingham berkshire and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 07. Juni 1983
    Geliefert am 14. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises 127 high street crawley west sussex title no wsx 10810 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 14. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1983
    Geliefert am 07. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises abutting balcome road horley surrey title no's sy 433645, sy 439369. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Apr. 1983
    Geliefert am 28. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land known as 129 high street crawley west sussex title no wsk 16446 together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 21. März 1983
    Geliefert am 07. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or lasomos limited and/or annes homes limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H 121-143 (odd nos) high st., Crawley west sussex (see doc M24).
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 1983
    Geliefert am 02. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from anns homes limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments & all premises 123, 125, 135, and 143 high street crawley west sussex together with all fixtures title nos wsx 4198 and wsx 35638.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Dez. 1982
    Geliefert am 24. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece of land on the west side of oakwood road horley, surrey. Title no. Sy 499634.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Dez. 1982
    Geliefert am 03. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at barkham ride/gorse ride, wokingham berkshire title no. Bk 127007.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 1982
    Geliefert am 11. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the and/or anns homes limited company to the charge on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    F/H sutural house geenthorne rd hammersmith london W6 title no ngl 210628.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 1982
    Geliefert am 05. Nov. 1982
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises situate and known as land known or formerly known as nos. 19,21,23 & 25 ferry road teddington, richmond upon thames, title no. Sgl 106709. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited.
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Mai 1982
    Geliefert am 27. Mai 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the south east side of treadwill road, epsom surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 27. Mai 1982Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Aug. 1981
    Geliefert am 20. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    139/141/143 kingston road new malden, surrey kingston upon thames title nos. Sgl 56724 sgl 304285, sy 242542. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 1980
    Geliefert am 24. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 6/6/79
    Kurze Angaben
    F/H ham street, ham, richmond upon thames, london.
    Berechtigte Personen
    • Trucanda Trusts Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat SUTURAL (PROPERTIES) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Apr. 2012Beginn der Liquidation
    24. Dez. 2015Soll aufgelöst werden am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Donald Mckinnon
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    Praktiker
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0