SG LEASING (DECEMBER) LIMITED

SG LEASING (DECEMBER) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSG LEASING (DECEMBER) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01219880
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SOCGEN LEASE LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    SOCIETE GENERALE (FRANCE) LEASING LIMITED18. Juli 197518. Juli 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2018

    6 SeitenLIQ03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lethbridge Fowler am 20. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom zum 15 Canada Square London E14 5GL am 23. Okt. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Sept. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 19. Sept. 2017

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of the share premium account to zero 19/09/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Lindsay Ginnette Sides als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Donald Cook als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG zum C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG am 02. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    5 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine ('Kasia') Marie Madeleine
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    British65878370001
    DENT, Nicholas Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish135237620002
    NIMMO, Mark Alexander
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    Sekretär
    36 Spencer Road
    SW18 2SW London
    British33420600001
    PARTRIDGE, William John
    C/O Societe Generale Balic
    60 Grace Church Street
    EC3V 0ND London
    Sekretär
    C/O Societe Generale Balic
    60 Grace Church Street
    EC3V 0ND London
    British28885720004
    AMADIEU, Daniel
    29 Bd Saint Denis
    92400 Courbevoie
    France
    Geschäftsführer
    29 Bd Saint Denis
    92400 Courbevoie
    France
    French39094630001
    BATAILLE, Alain
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    Geschäftsführer
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    French79407390001
    BISHOP, Julian Kenneth, Mr.
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish20351210002
    BUFFET, Alex Jaques Guy
    37 Alexandra Court
    171/175 Queensgate
    SW7 5HQ London
    Geschäftsführer
    37 Alexandra Court
    171/175 Queensgate
    SW7 5HQ London
    French37269510001
    BULLOCK, Gareth Richard
    47 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    47 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish86839910001
    CHANDLER, Stuart Rodwell
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    11 Vine Street
    EC1R 5DX London
    British59605380001
    CLAVEL, Jean-Louis
    Societe Generale Bank
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HD London
    Geschäftsführer
    Societe Generale Bank
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HD London
    French26985950002
    COLLINS, Michael John
    Tarring Culross Avenue
    RH16 1JF Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tarring Culross Avenue
    RH16 1JF Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish35138000001
    COOK, Stuart Donald
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    United KingdomBritish191477240004
    COXON, David
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    United KingdomBritish121539300001
    DEGAND, Jean Pierre
    38 Rue Ginoux
    75015 Paris
    France
    Geschäftsführer
    38 Rue Ginoux
    75015 Paris
    France
    French47193520001
    FLAIS, Jean Pierre
    Orion Holborn/Covent Garden
    94-99 High Holborn
    WC1 6LF London
    Geschäftsführer
    Orion Holborn/Covent Garden
    94-99 High Holborn
    WC1 6LF London
    French61299880001
    FREISZMOUTH LAGNICE, Gerard
    C/O Societe Generale
    Boulevard Uaussmann
    FOREIGN Paris
    France
    Geschäftsführer
    C/O Societe Generale
    Boulevard Uaussmann
    FOREIGN Paris
    France
    French28914280001
    GERARD, Thierry
    5 Cambridge Place
    W8 5PB London
    Geschäftsführer
    5 Cambridge Place
    W8 5PB London
    French33420560001
    HASTINGS, Christopher Alan
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    Geschäftsführer
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    United KingdomBritish68475890001
    HUET, Jean
    C/O Socgen Lease Ltd
    13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    Geschäftsführer
    C/O Socgen Lease Ltd
    13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    French27978610002
    JOLLY, Christopher Patrick
    13 Lansdowne Road
    Wimbledon
    SW20 8AN London
    Geschäftsführer
    13 Lansdowne Road
    Wimbledon
    SW20 8AN London
    United KingdomBritish29827710001
    MANIERE, Olivier Marie Xavier
    86 Rue De La Federation
    75015 Paris
    France
    Geschäftsführer
    86 Rue De La Federation
    75015 Paris
    France
    French51975060002
    MARCHAND, Jean Pierre
    137 Avenue De Wagram
    75017 Paris
    Geschäftsführer
    137 Avenue De Wagram
    75017 Paris
    French57505510001
    MAS, Jean Bernard
    C/O Societe Generale
    29 Boulevard Haussmann
    FOREIGN Paris 75009
    France
    Geschäftsführer
    C/O Societe Generale
    29 Boulevard Haussmann
    FOREIGN Paris 75009
    France
    British27774320001
    MEAGHER, Patrick Joseph
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British62293450003
    MESNIL, Marc Rene
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    Geschäftsführer
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    France75589840001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    OUDEA, Frederic Robert Andre
    Flat 9 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    Geschäftsführer
    Flat 9 Lansdowne Road
    W11 3AG London
    French51139830001
    PAGNI, Patrick
    C/O Societe Generale
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Geschäftsführer
    C/O Societe Generale
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    French33420570001
    PINARD, Herve Jean
    10 Promenade Mona Lisa
    Versailles
    78000 Yvelines
    France
    Geschäftsführer
    10 Promenade Mona Lisa
    Versailles
    78000 Yvelines
    France
    British35137990001
    ROY, Jean-Paul
    Socgen Lease Ltd 13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    Geschäftsführer
    Socgen Lease Ltd 13-17 Long Lane
    EC1A 9PN London
    French26985930001
    SERRES, Pascal
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    Geschäftsführer
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    French28885730001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    EnglandBritish212141970001
    STERN, Jean
    295 Rue St Jacques
    75005 Paris
    France
    Geschäftsführer
    295 Rue St Jacques
    75005 Paris
    France
    French26985960003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SG LEASING (DECEMBER) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sg Leasing (March) Limited
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales (Companies Act 2006)
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer00775046
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat SG LEASING (DECEMBER) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    The security assignment
    Erstellt am 13. Okt. 2009
    Geliefert am 29. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The drilling barge francisco de miranda 111 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Schlumberger Holdings Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    The security assignment
    Erstellt am 13. Okt. 2009
    Geliefert am 29. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The drilling barge francisco de miranda 112 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Schlumberger Holdings Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 2007
    Geliefert am 09. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in and to the goods under the hire purchase contract dated 31/12/2007,entitled agreement no 25. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First proprity mortgage
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 07. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest present and future in the goods,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. Juli 2007
    Geliefert am 10. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest, present and future in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 10. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest present and future in and to the goods, as defined in the hp contract.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest, present and future in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 29. Dez. 2006
    Geliefert am 08. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The goods in the hp contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest present and future in and to the goods meaning the hp contract meaning, the hire purchase contract dated 31 october 2006 and entitled agreement no. 19. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 05. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest present and future in and to the goods meaning the hp contract meaning, the hire purchase contract dated 29 september 2006 and entitled agreement no. 18. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged contracts and any sub-lease contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ecs United Kingdom PLC
    • Ecs United Kingdom PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security deed
    Erstellt am 23. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the tranche a facility lenders, the tranche c facility lenders and the tranche d facility lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest present and future, to and in the lease rights, assigned benefits and charged benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale S.a (London Branch)
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2005
    Geliefert am 11. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest, present and future in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 11. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2004
    Geliefert am 12. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee all interest present and future in the goods,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 13. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the goods in respect of the hp contract (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Head lessor assignment of insurances
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 20. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of security for the payment of the secured obligations, the head lessor with full title guarantee assigns absolutely and unconditionally and agrees to assign, the the intermediate lessor all the head lessors right title and interest in and to the assigned property. The owner and each partner warrant that as to itself it has not created any lien or other third party right on or over any of the assigned property other than pursuant to the assignment and the other transaction documents to which it is a party.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 15. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest present and future in and to the goods.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2003
    Geliefert am 16. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest, present and future in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment and restatement no.8 Relating to a security deed dated 25 october 1999
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Erworben am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 15. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the tranche a facility lenders and the tranche c facility lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights, title & interest, present & future to and in the lease rights, assigned benefits & charged benefits.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale S.A. (London Branch) (the New Mortgagee) as Successor to Banco Santandercentral Hispano S.A. London Branch (the Mortgagee)
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 26. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security deed
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 15. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the tranche a facility lenders and the tranche c facility lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Title and interest present and future to and the lease rights assigned benefits and charged benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale S.A. (London Branch) as Security Trustee Acting on Behalf of Itself and Theother Beneficiaries.
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest present and future in and to the goods.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest present and future in and to the goods.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest, present and future in and to the goods.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First priority mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in and to the goods as contained in the hp contract dated 21/10/2001,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electronic Data Systems Limited
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SG LEASING (DECEMBER) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Apr. 2019Aufgelöst am
    27. Sept. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0