OVAL OF BATH LIMITED
Überblick
Unternehmensname | OVAL OF BATH LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01224006 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OVAL OF BATH LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich OVAL OF BATH LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 16 Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury Wiltshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OVAL OF BATH LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WINDSOR GARAGE (BATH) LIMITED | 26. Aug. 1975 | 26. Aug. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OVAL OF BATH LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OVAL OF BATH LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Richard Cook als Geschäftsführer am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Christopher Walsh als Direktor am 01. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Luis Neulaender als Direktor am 01. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Richard Cook als Sekretär am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr John Richard Cook als Sekretär am 07. Juli 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Ian Makepeace als Sekretär am 07. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OVAL OF BATH LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEULAENDER, Richard Luis | Geschäftsführer | Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury 16 Wiltshire | England | British | Motor Dealer | 117461400002 | ||||
WALSH, John Christopher | Geschäftsführer | Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury 16 Wiltshire | England | British | Motor Dealer | 76089450002 | ||||
COOK, John Richard | Sekretär | Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury 16 Wiltshire | 199167710001 | |||||||
MAKEPEACE, Kevin Ian | Sekretär | Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury 16 Wiltshire England | British | 105075150001 | ||||||
MCLAREN, Ian George | Sekretär | Inverallen Fyfield Road Weyhill SP11 8DJ Andover Hampshire | British | Director | 29799910001 | |||||
QUIGGIN, Roger Frederick | Sekretär | Durham House 5 Hamilton Road Lansdown BA1 5SB Bath Avon | British | 14173410001 | ||||||
ROBERTS, Charles Thomas | Sekretär | 28 Church Street Southwick BA14 9RA Trowbridge Wiltshire | British | Chrtered Accountant | 38678820001 | |||||
COOK, John Richard | Geschäftsführer | Lower Road Churchfields SP2 7QD Salisbury 16 Wiltshire England | England | British | Director | 37813270005 | ||||
GARRITY, David John | Geschäftsführer | Elmar House 34a Hilperton Road BA14 7JD Trowbridge Wiltshire | British | Company Director | 14173420001 | |||||
QUIGGIN, Roger Frederick | Geschäftsführer | Stoneleigh Lodge Lansdown Road BA1 5TJ Bath Avon | British | Company Director | 14173410002 | |||||
ROBERTS, Charles Thomas | Geschäftsführer | 28 Church Street Southwick BA14 9RA Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | Chrtered Accountant | 38678820001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OVAL OF BATH LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitage Automotive Limited | 06. Apr. 2016 | Lower Road SP2 7QD Salisbury 16 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat OVAL OF BATH LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 21. März 2003 Geliefert am 26. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings at upper bristol road bath BA1 3AS t/n st 199022. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. März 2003 Geliefert am 21. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south side of upper bristol road bath t/no: ST199022. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juni 2000 Geliefert am 16. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee peugeot motor company PLC or psa finance PLC on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on south side of upper bristol road bath BA1 3AS t/no.ST182878 and all buildings fixtures fixed plant and machinery fixed charge over all moneys payable under present and future contracts or policies of insurance and the benefit of an option contained in a lease dated 22.12.99. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1999 Geliefert am 19. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The oval service station upper bristol road bath county of bath & north east somerset t/no: ST174953. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Used vehicle charge | Erstellt am 20. Dez. 1993 Geliefert am 21. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All its interest (if any) in any used and unused vehicles from time to time (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 25. Nov. 1993 Geliefert am 27. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Feb. 1992 Geliefert am 25. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Windsor service station, upper bristol road, bath, avon title number: AV1864. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Feb. 1992 Geliefert am 25. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures- see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Dez. 1990 Geliefert am 02. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 350,000 and all othre monies due or to become due from the company to the chargee, under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben L/H-windsor garage upper bristol road bath avon BA1 3AS. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
General charge mortgage | Erstellt am 24. Dez. 1990 Geliefert am 02. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H windsor garage upper bristol road bath avon BA1 3AS. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 09. Okt. 1990 Geliefert am 15. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 9/10/90 | |
Kurze Angaben All the chargors interest (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said assignment agreement and any monies received therefor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Apr. 1990 Geliefert am 26. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | ||
Kurze Angaben By way of legal mortgage the l/h property known as or being windsor windsor service station bristol bath avon including the entirety of the property comprised in title number av 1864 together with all buildings and fixtures thereon and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 12. Apr. 1990 Geliefert am 26. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | ||
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 12. Apr. 1990 Geliefert am 26. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as or being a garage site upper bristol road bath avon including the entirety of the property comprised in a lease dated 23/11/82 between bath city council (1) windsor garage (bath) LTD together with all buildings thereonand goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 24. Jan. 1986 Geliefert am 27. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 24-1-86 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the chargor's interest (if any) in any vehicle delivered to it the the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1985 Geliefert am 04. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 102,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H windsor service station, upper bristol road, bath avon with the goodwill of the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Feb. 1984 Geliefert am 24. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over all the company's present and future stock of new motor vehicles & all the proceeds of sale of such motor vehicles. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 25. Jan. 1980 Geliefert am 01. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Windsor service station, upper bristol road, bath avon, title no AV1864.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0