INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01225706 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NATIONWIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | 01. Apr. 1991 | 01. Apr. 1991 |
WESLEYSHIRE INDUSTRIAL SERVICES LIMITED | 20. Dez. 1984 | 20. Dez. 1984 |
WESLEYSHIRE LIMITED | 09. Sept. 1975 | 09. Sept. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Level 12 the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, England zum 30 Finsbury Square London EC2A 1AG am 08. Jan. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Dez. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 12 Seiten | MA | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Mark Williams am 19. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Dez. 2020 bis 31. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeremy Mark Williams als Direktor am 07. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Change of details for Maclellan Integrated Services Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Capital Tower 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England zum 30 Finsbury Square London EC2A 1AG am 02. Dez. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard John Butler als Geschäftsführer am 30. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Katherine Woods als Direktor am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mitie Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephanie Alison Pound als Sekretär am 30. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England |
| 148474450001 | ||||||||||
POUND, Stephanie Alison | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | Company Secretary | 213930870002 | ||||||||
WILLIAMS, Jeremy Mark | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Director | 280831530001 | ||||||||
WOODS, Katherine | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Director | 237400250001 | ||||||||
BRADBURY, Trevor | Sekretär | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | British | Company Secretary | 47884750003 | |||||||||
BUSH, Daniel | Sekretär | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | 241575560001 | |||||||||||
DAVIS, Hayden Keith | Sekretär | 1 Osborne B79 7SZ Tamworth Staffordshire | British | Company Secretary | 88452860001 | |||||||||
GRUNDY, David | Sekretär | 12 Saint Peters Close Stonnall WS9 9EN Walsall West Midlands | British | 67582170002 | ||||||||||
MCDONALD, Andrew John | Sekretär | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | 247565100001 | |||||||||||
MORROW, George Thomas Woodroofe | Sekretär | Carrant Brook House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Glos | British | 13876540001 | ||||||||||
POUND, Stephanie Alison | Sekretär | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | 250399460001 | |||||||||||
SHIPLEY, Stephen Robert | Sekretär | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | British | 16575040001 | ||||||||||
BADCOCK, Benjamin Edward | Geschäftsführer | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 125575240001 | ||||||||
BIGGS, Malcolm John | Geschäftsführer | 5 Dormston Close B91 3QW Solihull West Midlands | British | Company Director | 62229630001 | |||||||||
BRADBURY, Trevor | Geschäftsführer | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Company Secretary | 47884750003 | ||||||||
BUSH, Daniel | Geschäftsführer | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 182845350001 | ||||||||
BUTLER, Richard John | Geschäftsführer | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Finance Controller | 213849970003 | ||||||||
CLITHEROE, David Maurice | Geschäftsführer | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | Chartered Accountant | 49800090001 | |||||||||
CULLIFORD, John David | Geschäftsführer | 7 Cheveridge Close B91 3TT Solihull West Midlands | British | Director | 30684700001 | |||||||||
DAVIS, Hayden Keith | Geschäftsführer | 1 Osborne B79 7SZ Tamworth Staffordshire | United Kingdom | British | Accountant | 88452860001 | ||||||||
DAVIS, Paul Robert | Geschäftsführer | Honeyborne 25 Plymouth Road Barnt Green B45 8JF Birmingham West Midlands | British | Company Direcror | 3154980001 | |||||||||
ELLIS, John Leslie | Geschäftsführer | 21 Oakfields Avenue SG3 6NP Knebworth Hertfordshire | England | British | Director | 25380370003 | ||||||||
FELL, James Thomas | Geschäftsführer | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Group Financial Controller | 178128810002 | ||||||||
GRUNDY, David | Geschäftsführer | 12 Saint Peters Close Stonnall WS9 9EN Walsall West Midlands | England | British | Director | 67582170002 | ||||||||
HOWES, Peter Frederick Andrew | Geschäftsführer | 23 Harvington Drive Shirley B90 4YN Solihull West Midlands | British | Director | 30050860001 | |||||||||
KENNARD, Martin Robert | Geschäftsführer | Dingle Wood 8 Oak Grove DY10 3AL Kidderminster Worcestershire | British | Commercial Director | 10060690002 | |||||||||
MCDONALD, Andrew John | Geschäftsführer | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Company Secretary | 164670820001 | ||||||||
MORROW, George Thomas Woodroofe | Geschäftsführer | Carrant Brook House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Glos | England | British | Accountant | 13876540001 | ||||||||
OVERTON, David Anthony | Geschäftsführer | Blackdown 66 Tiddington Road CV37 7BA Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | Company Director | 38536590002 | ||||||||
SENDUR, Metin | Geschäftsführer | 31 Abberley Avenue DY13 0LZ Stourport On Severn Worcestershire | British | Director | 30050900001 | |||||||||
SHIPLEY, Stephen Robert | Geschäftsführer | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | England | British | Director | 16575040001 | ||||||||
STEVENTON, Brian George | Geschäftsführer | 4 Littleton Croft B91 3XR Solihull West Midlands | British | Director | 30050870001 | |||||||||
TAYLOR, Richard Ernest | Geschäftsführer | Briars Court Chapel Road RH8 0SX Oxted Surrey | British | Director | 67170590001 | |||||||||
WELLER, Lyndon Frank | Geschäftsführer | 37 Keswick Road B92 7PL Solihull West Midlands | British | Engineering Director | 30050890001 | |||||||||
WRAGG, Peter Graham | Geschäftsführer | Ibstone Cottage Grays Lane Ibstone HP14 3XX High Wycombe Buckinghamshire | British | Company Director | 37626480001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maclellan Integrated Services Limited | 06. Apr. 2016 | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12. The Shard England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Okt. 2000 Geliefert am 06. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 1991 Geliefert am 05. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 8, aston fields industrial estate bromsgrove worcestershire t/no:- hw 15473SEE form 395 for details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 05. Apr. 1988 Geliefert am 20. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the wesleyshire (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge:- l/h property k/a plot 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, worcester t/no: hw 15473 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts, uncalled capital. (For full details please see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmatory charge supplemental to a mortgage debenture | Erstellt am 05. Apr. 1988 Geliefert am 19. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemenetal to a mortgage debenture d/d 2.2.83 | |
Kurze Angaben The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmatory charge | Erstellt am 11. Mai 1983 Geliefert am 19. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage d/d 15.3.79 | |
Kurze Angaben L/H property known as unit 8 aston fields industrial estate bromsgrove. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. Feb. 1983 Geliefert am 08. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds it sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and see overleaf. All property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 15. März 1979 Geliefert am 30. März 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 8, aston fields industrial estate, bromsgrove, hereford and worcster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0