BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01226552 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLAKES HAULAGE LIMITED | 16. Sept. 1975 | 16. Sept. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Juni 2013
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jan Egtved Pedersen am 06. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Lauritzen am 06. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Tanjot Soar am 06. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsf ührer von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOAR, Tanjot | Sekretär | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | British | 123350000001 | ||||||
| LAURITZEN, Peter | Geschäftsführer | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | England | Danish | 123354600001 | |||||
| PEDERSEN, Jan Egtved | Geschäftsführer | Arla House, 4 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Yorkshire | England | Danish | 123347470001 | |||||
| BLAKE, Michael James | Sekretär | 3 Arthur Road CV37 6SJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 59309560001 | ||||||
| BLAKE, Simon Charles | Sekretär | 19 Albany Road CV37 6PG Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 45144840001 | ||||||
| MORTIMER, Robert Eric | Sekretär | 173 Loxley Road CV37 7DT Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 20909910001 | ||||||
| PRICE, John Philip | Sekretär | 20 Rossmore Court Park Road NW1 6XX London | British | 51592560002 | ||||||
| BLAKE, Geoffrey Donald | Geschäftsführer | Nelson House Banbury Road Ettington CV37 7SN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 20972610003 | ||||||
| BLAKE, Mary | Geschäftsführer | The Garden House Edstone B95 6DH Wootton Wawen Solihull West Midlands | British | 20909950001 | ||||||
| BLAKE, Norman Charles | Geschäftsführer | The Garden House Edstone B95 6DH Wootton Wawen Solihull West Midlands | British | 20972620001 | ||||||
| BLAKE, Patricia Margaret | Geschäftsführer | Nelson House 9 Banbury Road Ettington CV37 7SN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 20909940002 | ||||||
| BLAKE, Simon Charles | Geschäftsführer | The Hayloft Manor Barn Abberton Pershore Worcestershire | British | 45144840003 | ||||||
| BOWN, Simon Edgar | Geschäftsführer | Highfield Court Highfield Park Creaton NN6 8NT Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 59309710001 | |||||
| CLARK, Stephen John | Geschäftsführer | Beaumont House Evesham Road Salford Priors WR11 5UU Evesham Worcestershire | British | 49702240002 | ||||||
| GILBERT, Martin James | Geschäftsführer | 10 Knowle Green S17 3AP Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 65655390002 | |||||
| HODGE, Jeremy Spencer Carlton | Geschäftsführer | Highbury Bank Cottage Berkswell Road CV7 7LB Meriden West Midlands | British | 53503460001 | ||||||
| MACAULAY, Stephen William | Geschäftsführer | 309 Luton Road AL5 3LW Harpenden Hertfordshire | British | 64938250001 | ||||||
| MORTIMER, Robert Eric | Geschäftsführer | 173 Loxley Road CV37 7DT Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | 20909910001 | |||||
| MURPHY, Simon Alexander | Geschäftsführer | Cocksparrow Hall Coleshill Road Maxstoke B46 2QE Birmingham | United Kingdom | British | 24085730002 | |||||
| PEET, Nigel David | Geschäftsführer | 49 Heworth Village YO31 1AE York | United Kingdom | British | 26623160002 | |||||
| SMITH, Timothy John | Geschäftsführer | Swanland Lodge West End, Swanland HU14 3PE Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | 84729640001 | |||||
| WHITFIELD, Paul | Geschäftsführer | Manor Farm Brampton LN1 2EG Lincoln Lincolnshire | British | 89057170001 | ||||||
| WILKINS, Timothy Richard | Geschäftsführer | 10 Croxall Drive Shustoke Coleshill B46 2BH Birmingham West Midlands | British | 56023420001 | ||||||
| WRIGHT, Peter Brian | Geschäftsführer | 3 The Rowans Harvington WR11 5SX Evesham Worcestershire | British | 20909920001 | ||||||
| YEOMANS, Richard David | Geschäftsführer | Sandwood Curlew Drive West Charleton TQ7 2AA Kingsbridge Devon | British | 35983360002 |
Hat BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 8 july 1997 issued by the company | Erstellt am 21. Apr. 1999 Geliefert am 07. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: trailer no. T126, trailer type - norfrig thermoking fridge unit sbii (see continuation sheet to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1998 Geliefert am 30. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 1210 europa boulevard gemini business park warrington cheshire t/no.CH343012. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH november 1998 | Erstellt am 29. Okt. 1998 Geliefert am 09. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole the subjects on the south south east side of main street plains by airdrie t/no: LAN72995. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 21 august 1998 and | Erstellt am 12. Aug. 1998 Geliefert am 07. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Subject lying on the south side of mossburn avenue harthill t/n LAN98408. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1997 Geliefert am 16. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property known as abbey mills alcester heath alcester warwickshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Juli 1997 Geliefert am 14. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Juni 1991 Geliefert am 25. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a "chudleigh", birmingham road, kings coughton, alcester, warwickshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 25. Apr. 1990 Geliefert am 02. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. März 1987 Geliefert am 17. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H abbey mills alcester warwickshire and assigns the goodwill of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0