BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED

BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01226552
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLAKES HAULAGE LIMITED16. Sept. 197516. Sept. 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 601,984
    SH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Juni 2013

    • Kapital: GBP 601,984
    4 SeitenSH01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Juni 2013

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jan Egtved Pedersen am 06. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Lauritzen am 06. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Tanjot Soar am 06. Dez. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SOAR, Tanjot
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Sekretär
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    British123350000001
    LAURITZEN, Peter
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123354600001
    PEDERSEN, Jan Egtved
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanish123347470001
    BLAKE, Michael James
    3 Arthur Road
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    3 Arthur Road
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British59309560001
    BLAKE, Simon Charles
    19 Albany Road
    CV37 6PG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    19 Albany Road
    CV37 6PG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British45144840001
    MORTIMER, Robert Eric
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20909910001
    PRICE, John Philip
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    Sekretär
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    British51592560002
    BLAKE, Geoffrey Donald
    Nelson House Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Nelson House Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20972610003
    BLAKE, Mary
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    Geschäftsführer
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    British20909950001
    BLAKE, Norman Charles
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    Geschäftsführer
    The Garden House
    Edstone
    B95 6DH Wootton Wawen
    Solihull West Midlands
    British20972620001
    BLAKE, Patricia Margaret
    Nelson House 9 Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Nelson House 9 Banbury Road
    Ettington
    CV37 7SN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20909940002
    BLAKE, Simon Charles
    The Hayloft
    Manor Barn Abberton
    Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Hayloft
    Manor Barn Abberton
    Pershore
    Worcestershire
    British45144840003
    BOWN, Simon Edgar
    Highfield Court Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Highfield Court Highfield Park
    Creaton
    NN6 8NT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish59309710001
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    British49702240002
    GILBERT, Martin James
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish65655390002
    HODGE, Jeremy Spencer Carlton
    Highbury Bank Cottage
    Berkswell Road
    CV7 7LB Meriden
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Highbury Bank Cottage
    Berkswell Road
    CV7 7LB Meriden
    West Midlands
    British53503460001
    MACAULAY, Stephen William
    309 Luton Road
    AL5 3LW Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    309 Luton Road
    AL5 3LW Harpenden
    Hertfordshire
    British64938250001
    MORTIMER, Robert Eric
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    173 Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish20909910001
    MURPHY, Simon Alexander
    Cocksparrow Hall Coleshill Road
    Maxstoke
    B46 2QE Birmingham
    Geschäftsführer
    Cocksparrow Hall Coleshill Road
    Maxstoke
    B46 2QE Birmingham
    United KingdomBritish24085730002
    PEET, Nigel David
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    Geschäftsführer
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    United KingdomBritish26623160002
    SMITH, Timothy John
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish84729640001
    WHITFIELD, Paul
    Manor Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Brampton
    LN1 2EG Lincoln
    Lincolnshire
    British89057170001
    WILKINS, Timothy Richard
    10 Croxall Drive
    Shustoke Coleshill
    B46 2BH Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Croxall Drive
    Shustoke Coleshill
    B46 2BH Birmingham
    West Midlands
    British56023420001
    WRIGHT, Peter Brian
    3 The Rowans
    Harvington
    WR11 5SX Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    3 The Rowans
    Harvington
    WR11 5SX Evesham
    Worcestershire
    British20909920001
    YEOMANS, Richard David
    Sandwood Curlew Drive
    West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Geschäftsführer
    Sandwood Curlew Drive
    West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    British35983360002

    Hat BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 8 july 1997 issued by the company
    Erstellt am 21. Apr. 1999
    Geliefert am 07. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: trailer no. T126, trailer type - norfrig thermoking fridge unit sbii (see continuation sheet to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 1998
    Geliefert am 30. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1210 europa boulevard gemini business park warrington cheshire t/no.CH343012. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH november 1998
    Erstellt am 29. Okt. 1998
    Geliefert am 09. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the south south east side of main street plains by airdrie t/no: LAN72995.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21 august 1998 and
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 07. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Subject lying on the south side of mossburn avenue harthill t/n LAN98408.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Juli 1997
    Geliefert am 16. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as abbey mills alcester heath alcester warwickshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Juli 1997
    Geliefert am 14. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 20. Juni 1991
    Geliefert am 25. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a "chudleigh", birmingham road, kings coughton, alcester, warwickshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 25. Apr. 1990
    Geliefert am 02. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 09. März 1987
    Geliefert am 17. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H abbey mills alcester warwickshire and assigns the goodwill of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BLAKES CHILLED DISTRIBUTION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. März 2014Aufgelöst am
    19. Juni 2013Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0