MMF LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMMF LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01229140
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MMF LIMITED?

    • Großhandel mit anderen speziellen Produkten (46180) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich MMF LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 2 Demuth Way
    Junction 2 Industrial Estate
    B69 4LT Oldbury
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MMF LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    M. M. F. MIDLANDS LIMITED12. Dez. 198312. Dez. 1983
    M. M. F. DUCTWORK LIMITED08. Okt. 197508. Okt. 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MMF LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für MMF LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Units 15-16 Colthrop Business Park Colthrop Lane Thatcham Berkshire RG19 4NB zum Unit 2 Demuth Way Junction 2 Industrial Estate Oldbury B69 4LT am 11. Juni 2018

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Allister John Moorcroft als Geschäftsführer am 13. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Patrick Ian Simpson als Direktor am 13. Sept. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Allister John Moorcroft als Sekretär am 13. Sept. 2017

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Allister John Moorcroft am 30. Sept. 2016

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Allister John Moorcroft am 30. Sept. 2016

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1,100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David John Price als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Kevin Whittle als Geschäftsführer am 01. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan John Turberville als Geschäftsführer am 01. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1,100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Philip Thomas Mangnall als Geschäftsführer am 01. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MMF LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SIMPSON, Patrick Ian
    Demuth Way
    Junction 2 Industrial Estate
    B69 4LT Oldbury
    Unit 2
    England
    Geschäftsführer
    Demuth Way
    Junction 2 Industrial Estate
    B69 4LT Oldbury
    Unit 2
    England
    EnglandIrish198782000001
    BEARD, Antony James
    4 Woodcock Way Castleton Park
    Off Nottingham Road
    LE65 1AX Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Sekretär
    4 Woodcock Way Castleton Park
    Off Nottingham Road
    LE65 1AX Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British72111010002
    FORD, Anthony John
    Sunrise 63 Lymington Bottom
    Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Sekretär
    Sunrise 63 Lymington Bottom
    Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    British51028240001
    GRAINGER, Hannah Bernadette
    Petros 11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    Petros 11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British16665810001
    MOORCROFT, Allister John
    55 Woodburn Road
    B66 2PU Smethwick
    Flue House
    West Midlands
    England
    Sekretär
    55 Woodburn Road
    B66 2PU Smethwick
    Flue House
    West Midlands
    England
    167520440001
    BEARD, Antony James
    4 Woodcock Way Castleton Park
    Off Nottingham Road
    LE65 1AX Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    4 Woodcock Way Castleton Park
    Off Nottingham Road
    LE65 1AX Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British72111010002
    FORD, Anthony John
    Sunrise 63 Lymington Bottom
    Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Sunrise 63 Lymington Bottom
    Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    EnglandBritish51028240001
    GOULDEN, Peter Anthony
    Beechings Water Street
    Hampstead Norreys
    RG18 0SB Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Beechings Water Street
    Hampstead Norreys
    RG18 0SB Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish15602430001
    GRAINGER, Hannah Bernadette
    Petros 11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Petros 11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British16665810001
    GRAINGER, Thomas William
    11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    11 Middleton Road
    Streetly
    B74 3EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandIrish16665820001
    HORNBY, John
    39 Sidlaw Close
    B63 1JS Halesowen
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 Sidlaw Close
    B63 1JS Halesowen
    West Midlands
    British70222450001
    MANGNALL, Philip Thomas
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish148100310003
    MCIVOR, Terence Alphonsus
    7 Ventnor Terrace
    TR26 1DY St Ives
    Cornwall
    Geschäftsführer
    7 Ventnor Terrace
    TR26 1DY St Ives
    Cornwall
    EnglandBritish28336690002
    MOORCROFT, Allister John
    55 Woodburn Road
    B66 2PU Smethwick
    Flue House
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    55 Woodburn Road
    B66 2PU Smethwick
    Flue House
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish9661230003
    PRICE, David John
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    EnglandBritish35415160005
    REYNOLDS, Peter James
    Brackendale Byslips Road
    Studham
    LU6 2ND Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Brackendale Byslips Road
    Studham
    LU6 2ND Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish13722950001
    THOMAS, David Robert
    Flat 1 Bath Mews
    29 Greenfields Avenue
    DY8 1SX Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Flat 1 Bath Mews
    29 Greenfields Avenue
    DY8 1SX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish7819870002
    TURBERVILLE, Alan John
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    EnglandBritish156654420002
    WHITTLE, Stephen Kevin
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Colthrop Business Park
    Colthrop Lane
    RG19 4NB Thatcham
    Units 15-16
    Berkshire
    England
    EnglandBritish167658150001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MMF LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Docherty Chimney Group Limited
    Colthorp Lane
    RG19 4NB Thatcham
    15 Colthorp Business Park
    Berkshire
    England
    06. Apr. 2016
    Colthorp Lane
    RG19 4NB Thatcham
    15 Colthorp Business Park
    Berkshire
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House, Cardiff
    Registrierungsnummer03934327
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MMF LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2012
    Geliefert am 10. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 victoria street, mansfield t/no NT242650; by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets & the rents receivable from any lease granted out of the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 02. März 2012
    Geliefert am 10. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2012
    Geliefert am 10. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Crowley road swalwell gateshead t/no.TY105393 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 02. März 2012
    Geliefert am 10. März 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Erstellt am 03. Juni 2011
    Geliefert am 07. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 07. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 16. Mai 2011
    Geliefert am 26. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £22,508.40 and any additional sum held pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Tilfen Land Limited
    Transaktionen
    • 26. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal assignment
    Erstellt am 07. März 2011
    Geliefert am 08. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 2011
    Geliefert am 15. Jan. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 15 victoria street, mansfield, t/no NT242650 and the f/h property on the south side of crowley road, t/no TY105393. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the south side of crowley road, swalwell, gateshead, t/no TY105393. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property k/a 15 victoria street, mansfield t/no NT242650. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. März 2005
    Geliefert am 09. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Enterprise Finance Europe (UK) LTD
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Sept. 2000
    Geliefert am 23. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a lease of unit 5 manor park,manor road,erith,kent dated 21 september 2000 and under this deed
    Kurze Angaben
    £19,558.75 deposited as security for all monies due under the provisions of this deed and all interest and other monies thereon.
    Berechtigte Personen
    • Agf Insurance Limited
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2000
    Geliefert am 05. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2000
    Geliefert am 05. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 victoria mansfield nottinghamshire - NT242650. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2000
    Geliefert am 05. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the south side of crowley swalwell gateshead tyne & wear - TY105393. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 24. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    55 woodburn road smethwick t/n WM518733. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 04. Nov. 1997
    Geliefert am 05. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises at crowley road swalwell gateshead tyne & wear t/no.TY105393. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 04. März 1993
    Erworben am 23. Juni 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1992
    Geliefert am 02. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Selkirk Manufacturing Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 18. Okt. 1991
    Erworben am 23. Juni 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Repairs deposit agreement
    Erstellt am 19. Juli 1989
    Geliefert am 20. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the interest of the company in the said deposit account opened at royal bank of scotland PLC in the name of sun life assurance society PLC and the company presently in the sum of 8000.
    Berechtigte Personen
    • Sun Life Assurance Society
    Transaktionen
    • 20. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 03. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1989
    Geliefert am 10. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 15 victoria street, mansfield, nottinghamshire assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 06. Feb. 1989
    Erworben am 23. Juni 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 31. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0