MMF LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MMF LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01229140 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MMF LIMITED?
- Großhandel mit anderen speziellen Produkten (46180) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich MMF LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2 Demuth Way Junction 2 Industrial Estate B69 4LT Oldbury England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MMF LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| M. M. F. MIDLANDS LIMITED | 12. Dez. 1983 | 12. Dez. 1983 |
| M. M. F. DUCTWORK LIMITED | 08. Okt. 1975 | 08. Okt. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MMF LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MMF LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Units 15-16 Colthrop Business Park Colthrop Lane Thatcham Berkshire RG19 4NB zum Unit 2 Demuth Way Junction 2 Industrial Estate Oldbury B69 4LT am 11. Juni 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Allister John Moorcroft als Geschäftsführer am 13. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Patrick Ian Simpson als Direktor am 13. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Allister John Moorcroft als Sekretär am 13. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Allister John Moorcroft am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Allister John Moorcroft am 30. Sept. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Price als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Kevin Whittle als Geschäftsführer am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan John Turberville als Geschäftsführer am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Thomas Mangnall als Geschäftsführer am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MMF LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPSON, Patrick Ian | Geschäftsführer | Demuth Way Junction 2 Industrial Estate B69 4LT Oldbury Unit 2 England | England | Irish | 198782000001 | |||||
| BEARD, Antony James | Sekretär | 4 Woodcock Way Castleton Park Off Nottingham Road LE65 1AX Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 72111010002 | ||||||
| FORD, Anthony John | Sekretär | Sunrise 63 Lymington Bottom Four Marks GU34 5AH Alton Hampshire | British | 51028240001 | ||||||
| GRAINGER, Hannah Bernadette | Sekretär | Petros 11 Middleton Road Streetly B74 3EU Sutton Coldfield West Midlands | British | 16665810001 | ||||||
| MOORCROFT, Allister John | Sekretär | 55 Woodburn Road B66 2PU Smethwick Flue House West Midlands England | 167520440001 | |||||||
| BEARD, Antony James | Geschäftsführer | 4 Woodcock Way Castleton Park Off Nottingham Road LE65 1AX Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 72111010002 | ||||||
| FORD, Anthony John | Geschäftsführer | Sunrise 63 Lymington Bottom Four Marks GU34 5AH Alton Hampshire | England | British | 51028240001 | |||||
| GOULDEN, Peter Anthony | Geschäftsführer | Beechings Water Street Hampstead Norreys RG18 0SB Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 15602430001 | |||||
| GRAINGER, Hannah Bernadette | Geschäftsführer | Petros 11 Middleton Road Streetly B74 3EU Sutton Coldfield West Midlands | British | 16665810001 | ||||||
| GRAINGER, Thomas William | Geschäftsführer | 11 Middleton Road Streetly B74 3EU Sutton Coldfield West Midlands | England | Irish | 16665820001 | |||||
| HORNBY, John | Geschäftsführer | 39 Sidlaw Close B63 1JS Halesowen West Midlands | British | 70222450001 | ||||||
| MANGNALL, Philip Thomas | Geschäftsführer | Colthrop Business Park Colthrop Lane RG19 4NB Thatcham Units 15-16 Berkshire England | United Kingdom | British | 148100310003 | |||||
| MCIVOR, Terence Alphonsus | Geschäftsführer | 7 Ventnor Terrace TR26 1DY St Ives Cornwall | England | British | 28336690002 | |||||
| MOORCROFT, Allister John | Geschäftsführer | 55 Woodburn Road B66 2PU Smethwick Flue House West Midlands England | United Kingdom | British | 9661230003 | |||||
| PRICE, David John | Geschäftsführer | Colthrop Business Park Colthrop Lane RG19 4NB Thatcham Units 15-16 Berkshire England | England | British | 35415160005 | |||||
| REYNOLDS, Peter James | Geschäftsführer | Brackendale Byslips Road Studham LU6 2ND Dunstable Bedfordshire | England | British | 13722950001 | |||||
| THOMAS, David Robert | Geschäftsführer | Flat 1 Bath Mews 29 Greenfields Avenue DY8 1SX Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 7819870002 | |||||
| TURBERVILLE, Alan John | Geschäftsführer | Colthrop Business Park Colthrop Lane RG19 4NB Thatcham Units 15-16 Berkshire England | England | British | 156654420002 | |||||
| WHITTLE, Stephen Kevin | Geschäftsführer | Colthrop Business Park Colthrop Lane RG19 4NB Thatcham Units 15-16 Berkshire England | England | British | 167658150001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MMF LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docherty Chimney Group Limited | 06. Apr. 2016 | Colthorp Lane RG19 4NB Thatcham 15 Colthorp Business Park Berkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MMF LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 02. März 2012 Geliefert am 10. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 15 victoria street, mansfield t/no NT242650; by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets & the rents receivable from any lease granted out of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 2012 Geliefert am 10. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 2012 Geliefert am 10. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Crowley road swalwell gateshead t/no.TY105393 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 2012 Geliefert am 10. März 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on non-vesting debts and floating charge | Erstellt am 03. Juni 2011 Geliefert am 07. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 16. Mai 2011 Geliefert am 26. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £22,508.40 and any additional sum held pursuant to the terms of the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment | Erstellt am 07. März 2011 Geliefert am 08. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Jan. 2011 Geliefert am 15. Jan. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 15 victoria street, mansfield, t/no NT242650 and the f/h property on the south side of crowley road, t/no TY105393. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Apr. 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a the south side of crowley road, swalwell, gateshead, t/no TY105393. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Apr. 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the f/h property k/a 15 victoria street, mansfield t/no NT242650. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 2005 Geliefert am 09. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. Sept. 2000 Geliefert am 23. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a lease of unit 5 manor park,manor road,erith,kent dated 21 september 2000 and under this deed | |
Kurze Angaben £19,558.75 deposited as security for all monies due under the provisions of this deed and all interest and other monies thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 15 victoria mansfield nottinghamshire - NT242650. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the south side of crowley swalwell gateshead tyne & wear - TY105393. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Juni 1998 Geliefert am 24. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 55 woodburn road smethwick t/n WM518733. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 04. Nov. 1997 Geliefert am 05. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at crowley road swalwell gateshead tyne & wear t/no.TY105393. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 04. März 1993 Erworben am 23. Juni 1997 Geliefert am 08. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Okt. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 18. Okt. 1991 Erworben am 23. Juni 1997 Geliefert am 08. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Repairs deposit agreement | Erstellt am 19. Juli 1989 Geliefert am 20. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All the interest of the company in the said deposit account opened at royal bank of scotland PLC in the name of sun life assurance society PLC and the company presently in the sum of 8000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1989 Geliefert am 10. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 15 victoria street, mansfield, nottinghamshire assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 06. Feb. 1989 Erworben am 23. Juni 1997 Geliefert am 08. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0