CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01230067 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CITY CAMERA EXCHANGE (HOLDINGS) LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| CITY CAMERA EXCHANGE LIMITED | 16. Okt. 1975 | 16. Okt. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Molyneux als Sekretär am 20. März 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Hannan als Geschäftsführer am 26. Okt. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Joanna Boydell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Chris Yates als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Emmett als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Joanna Boydell als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cashman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Hannan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Cashman als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für William Peter Rollason am 23. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| EMMETT, Sean Robert | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 152701300001 | |||||
| YATES, Chris Paul | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 152699330001 | |||||
| CRABTREE, John Nigel | Sekretär | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | British | 48224770001 | ||||||
| MACKINNON, Kenneth | Sekretär | Tall Pines 31 The Gateway Woodham GU21 5SN Woking Surrey | British | 8257240002 | ||||||
| MOLYNEUX, Nicholas John | Sekretär | 168 Kenrick Road Mapperley NG3 6EX Nottingham Nottinghamshire | British | 93529300001 | ||||||
| CASHMAN, David Peter Charles | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 151553190001 | |||||
| CHURCHILL, Roger | Geschäftsführer | 61 Sapcote Road Burbage LE10 2AS Hinckley Leicestershire | British | 48957720002 | ||||||
| COLLINS, Ivan Trevor | Geschäftsführer | 66 Romney Drive BR1 2TE Bromley Kent | British | 8257250001 | ||||||
| CRABTREE, John Nigel | Geschäftsführer | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 48224770001 | |||||
| GIDDINGS, Michael John | Geschäftsführer | 3 Nailsworth Road Dorridge B93 8NS Solihull West Midlands | British | 105128310002 | ||||||
| HANNAN, Andrew | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 153976980001 | |||||
| HARRIS, Ian Michael Brian | Geschäftsführer | Meadowsteep Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 116885790001 | |||||
| LACEY, Andrew | Geschäftsführer | 67 Gilders Raod KT9 2AE Chessington Surrey | British | 18820850003 | ||||||
| MACKINNON, Kenneth | Geschäftsführer | Tall Pines 31 The Gateway Woodham GU21 5SN Woking Surrey | British | 8257240002 | ||||||
| REDPATH, James | Geschäftsführer | 16 Bosworth Way NG10 1EA Long Eaton Nottinghamshire | England | British | 123915050001 | |||||
| RIORDAN, Peter Joseph | Geschäftsführer | 73 Fairfax Avenue Ewell KT17 2QQ Epsom Surrey | United Kingdom | British | 106574800001 | |||||
| ROLLASON, William Peter | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester | United Kingdom | British | 67354680003 |
Hat CITY CAMERA EXCHANGE HOLBORN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 30. Aug. 2007 Geliefert am 17. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental deed | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 19. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Juni 1991 Geliefert am 28. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Feb. 1989 Geliefert am 17. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 23. Dez. 1985 Geliefert am 09. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 09. Nov. 1982 Geliefert am 15. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0