C.L.C. CONTRACTORS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | C.L.C. CONTRACTORS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01230435 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
- Elektroinstallation (43210) / Bauwesen
- Sonstige Bauinstallationen (43290) / Bauwesen
- Malerarbeiten (43341) / Bauwesen
- Sonstige Bauabschlüsse und -fertigstellungen (43390) / Bauwesen
Wo befindet sich C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2 Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLC CONTRACTORS (SOUTHERN) LIMITED | 20. Okt. 1975 | 20. Okt. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Jan. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 19. Jan. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Best ätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Jan. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2026 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Ryder am 15. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Clc Group Limited as a person with significant control on 01. Juli 2025 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2025 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr James Robert Stamp als Direktor am 01. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor am 01. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Andrew Hilton als Geschäftsführer am 01. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Iain Armitage als Geschäftsführer am 31. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2024 bis 31. März 2025 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012304350017, erstellt am 25. Sept. 2024 | 14 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 012304350016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012304350016, erstellt am 22. Aug. 2023 | 9 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 10 Seiten | MA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 012304350014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 012304350015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 34 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 40 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Marris als Geschäftsführer am 30. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 41 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOAL, Robert | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 123847700001 | |||||
| ELLIOTT, Lee | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 253995000001 | |||||
| HILTON, Matthew Simon | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 209112520001 | |||||
| MCDONALD, Adrian John | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 94505040001 | |||||
| MORRIS, Richard | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 190653350001 | |||||
| PRITCHARD, Christopher Paul | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | Gb-Eng | British | 147463160001 | |||||
| REEVE, Simon | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 219644110001 | |||||
| RYDER, John Robert | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | United Kingdom | British | 209112660001 | |||||
| STAMP, James Robert | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 341035800001 | |||||
| TRINER, Michael James | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 240253680001 | |||||
| ARMITAGE, Richard Simon | Sekretär | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | 179993220001 | |||||||
| CHILDERSTONE-PARRETT, Joanne | Sekretär | Blackstone House Upper Crabbick Lane Denmead PO7 6HQ Waterlooville Hampshire | British | 23304780001 | ||||||
| EAVES, Terence Joseph | Sekretär | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | British | 125796830001 | ||||||
| ILES, Mark Willmott | Sekretär | 209 Cutbush Lane Townhill Park SO18 2GF Southampton Hampshire | British | 23509110002 | ||||||
| WHITE, Malcolm John | Sekretär | Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton Unit 2 Hampshire United Kingdom | British | 110398690002 | ||||||
| AINSLEY, Stanley | Geschäftsführer | 17 Chetwynd Road Bassett SO16 3JA Southampton | British | 62660370003 | ||||||
| ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas | Geschäftsführer | Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton Unit 2 Hampshire United Kingdom | England | British | 72943340002 | |||||
| ARMITAGE, Philip Iain | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 85173470003 | |||||
| ARMITAGE, Richard Simon | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 146747640001 | |||||
| BEATTIE, Paul | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 170492950001 | |||||
| BOWERS, Anthony Charles | Geschäftsführer | 30 Firs Drive Hedge End SO30 4QL Southampton Hampshire | British | 7004850002 | ||||||
| CARTER, Ian Paul | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 | England | British | 79314210003 | |||||
| CHESELDINE, John Paul, Director | Geschäftsführer | 7 Burton Mews Washingborough LN4 1TA Lincoln Lincolnshire | British | 23318530001 | ||||||
| CHILDERSTONE, William James | Geschäftsführer | 53 Brampton Towers SO16 7FB Southampton Hampshire | British | 42598030001 | ||||||
| CRAIGS, Grahame | Geschäftsführer | 34 Humford Way Bayard Wood NE22 5ET Bedlington Northumberland | United Kingdom | British | 36796550001 | |||||
| CROSHAW, Raymond Denis | Geschäftsführer | Hillcrest 39 Cockney Hill Tilehurst RG30 4HF Reading | British | 52481170001 | ||||||
| DOIG, David Peter | Geschäftsführer | Northbrook Ind Estate Vincent Avenue SO16 6PQ Southampton Unit 2 England | England | British | 191795540001 | |||||
| DRURY, Peter John | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 16238220001 | |||||
| EAVES, Terence Joseph | Geschäftsführer | 86 Spencer Road PO33 3AH Ryde Isle Of Wight | England | British | 125796830001 | |||||
| EVERETT, Mervyn Stanley | Geschäftsführer | 12 Rothbury Close TS17 0YR Ingleby Barwick Cleveland | British | 84176160002 | ||||||
| FENTON, Geoffrey Alan | Geschäftsführer | 73 Princess Victoria Street BS8 4DD Bristol | Great Britain | British | 90438270001 | |||||
| GOODHIND, Richard John | Geschäftsführer | Eyresdown Alderholt Road, Sandleheath SP6 1PT Fordingbridge Hampshire | British | 118179370001 | ||||||
| HARRY, David Michael | Geschäftsführer | Vincent Avenue Shirley SO16 6PQ Southampton Unit 2 Hampshire United Kingdom | England | British | 110122850001 | |||||
| HILTON, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | England | British | 102101760001 | |||||
| HOLLAND, Nigel Patrick, Director | Geschäftsführer | 2 Riverside Cottages SO24 9BE Alresford Hampshire | British | 23318550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei C.L.C. CONTRACTORS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Clc Group Limited | 06. Apr. 2016 | Northbrook Industrial Estate Vincent Avenue SO16 6PB Southampton Unit 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0