AIR 2000 AVIATION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAIR 2000 AVIATION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01232085
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    • Nichtlinienflugverkehr für Passagiere (51102) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OWNERS ABROAD AVIATION LIMITED11. Juli 198411. Juli 1984
    OWNERS ABROAD WHOLESALE LIMITED 03. Nov. 197503. Nov. 1975

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 22. Mai 2012

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 09. Mai 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 15. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 16. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 24. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs. Joyce Walter am 24. Juni 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von AIR 2000 AVIATION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Sekretär
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    British76169540002
    BROWNE, Christine Margaret
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish79573340002
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish76169540003
    BUCKLEY, Peter Eric
    Pine Lodge
    Worthing Road Southwater
    RH13 9AT Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    Pine Lodge
    Worthing Road Southwater
    RH13 9AT Horsham
    West Sussex
    English14052080002
    STARLING, Rebecca Jean Godwin
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    Sekretär
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    British45381850004
    ADDISON SMITH, Nigel
    49 Fullerton Road
    Wandsworth
    SW18 1BU London
    Geschäftsführer
    49 Fullerton Road
    Wandsworth
    SW18 1BU London
    British46750900002
    ALLARD, Roger Jeffrey
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    Geschäftsführer
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    United KingdomEnglish81122260002
    BRYANT, Robert David
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Dorill
    Church Road, Buxted
    TN22 4LT Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish152320790001
    BUNN, James Richard
    Great Lime Kiln
    RH13 9JL Southwater
    28
    West Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Lime Kiln
    RH13 9JL Southwater
    28
    West Sussex
    United Kingdom
    British98013270002
    GILL, David Alan
    5 Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Chanctonbury Drive
    SL5 9PT Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish37437870002
    HEALD, Malcolm Barclay
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish1605080001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    HUMPHRIES, Michael
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    3 Paget Close
    RH13 6HD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish38432430001
    KLEIN, Howard Malcolm
    14 Claybury Hall
    Repton Park
    IG8 8RW Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Claybury Hall
    Repton Park
    IG8 8RW Woodford Green
    Essex
    British105173540001
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    GbrBritish32619030002
    MOIR, Lance Stuart
    86 Riversdale Road
    N5 2JZ London
    Geschäftsführer
    86 Riversdale Road
    N5 2JZ London
    British51082180002
    SALMON, Tina
    31 Waverley Avenue
    Chingford
    E4 8HS London
    Geschäftsführer
    31 Waverley Avenue
    Chingford
    E4 8HS London
    British28958240001
    SEMPLE, Alan Haig
    Foxley House 20 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Foxley House 20 Lynch Hill Park
    RG28 7NF Whitchurch
    Hampshire
    British67061580001
    SINCLAR, Vari
    8 Bethune Close
    Worth
    RH10 7WB Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    8 Bethune Close
    Worth
    RH10 7WB Crawley
    West Sussex
    British38474450001
    SMITH, Kenneth William
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    Geschäftsführer
    10 Martello Mews
    BN25 1JT Seaford
    East Sussex
    British87819940001
    STEVENS, Robert
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Chiltenhurst
    TN8 5PJ Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish83941990001
    STONE, Geofrey George
    7 Harcourt Manor
    Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    7 Harcourt Manor
    Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish44562670002

    Hat AIR 2000 AVIATION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed relating to netting and payment arrangements
    Erstellt am 28. Feb. 1997
    Geliefert am 12. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any obligation for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, joint or several and whether incurred as principal or surety, including principal, interest, commission, fees and other lawful charges and expenses for which a participant (as defined) may be or become liable to the chargee (in its capacity as security trustee) and the banks (as defined)
    Kurze Angaben
    By clause 3.1 of the deed, the company agreed that each bank may, at any time or times on or after the enforcement date (as defined in the inter-creditor agreement) without notice, set off any or all sums of money now or subsequently standing to the credit of the company (including any unmatured deposit or any deposit in respect of which the appropriate call notice has not been given) against all or such part of such indebtedness as such bank may determine (whether presently payable or not).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over deposit
    Erstellt am 30. Okt. 1990
    Geliefert am 19. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 30/10/90 and/or this charge
    Kurze Angaben
    The aggregate amount at any relevant time standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company opened, or as the code may be, to be opened in the books of mars nominees LTD. (Please see 395 M82 for details).
    Berechtigte Personen
    • Guinness & Mahon Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 12. Apr. 1989
    Geliefert am 21. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 12/4/89 and this charge
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in and to all monies which wereat the date of assignment (see 395 & cont sheet m 125C for details).
    Berechtigte Personen
    • Guinness & Mahon Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 20. Okt. 1988
    Geliefert am 09. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 20 oct 1988 and this charge.
    Kurze Angaben
    All the companys rights title and interest in and to all moneys standing to the credit of the blocked deposit accounts in the name of the company.
    Berechtigte Personen
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 28. Sept. 1988
    Geliefert am 18. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement of even date and this charge
    Kurze Angaben
    The aggregate amount standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company open or to be opened in the books of guinness mahon nominees limited ( see form 395 and continuation sheet relevant to the charge ).
    Berechtigte Personen
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 01. Dez. 1987
    Geliefert am 08. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Boeing modle 727-217 reg. Mark g - nroa serial no- 21056 engines serial nos 686371, 688042 and 707910.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Feb. 1987
    Geliefert am 26. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One boeing 727-217 aircraft with reg. No g-nroa including all spare parts and all spare aircraft engines for the aircraft.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Agreement
    Erstellt am 23. Mai 1986
    Geliefert am 31. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    An amount standing to the credit of a bank acount which shall not exceed a maximum amount of £300,000 together with the pull amount of any balance of sale proceeds relating to the sale of an aircraft remaining after any mortgages have been discharged in full.
    Kurze Angaben
    A bank account and the balance of sale proceeds.
    Berechtigte Personen
    • Dan-Air Services Limited
    Transaktionen
    • 31. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 18. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1986
    Geliefert am 27. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86
    Kurze Angaben
    All the companys present & future lights benefite & interest in the boeing 727 -217 advanced net air craft & manufacturers serial number 21056. and UK registration mark g- nroa, its engines any replacement and equipment from time to time installed thereof the insurances (other than liability mcullances) and earnings of the aircraft.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 27. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 23. Mai 1986
    Geliefert am 27. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86
    Kurze Angaben
    All the companies rights title and interest to and in any monies payable to the company under an aircraft lease agreement dated 01/12/83. (see doc M27 for full details) and all the companies rights, title and interest to arain any monies whatsoever payable to the company under a guarantee issued on 25/05/86 by lloyds bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 27. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 22. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Mai 1986
    Geliefert am 27. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 03. Feb. 1986
    Geliefert am 06. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27/11/85
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 19. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 01. Dez. 1983
    Geliefert am 02. Dez. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee following the termination in certain circumstances of an aircraft lease agreement dated 1-12-83
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest to the relevant proportion of the remaining net sales proceeds (all as defined in the said charge and/or aircraft lease agreement).
    Berechtigte Personen
    • Dan-Air Services Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1983Registrierung einer Belastung
    Deed
    Erstellt am 01. Dez. 1983
    Geliefert am 02. Dez. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30TH november 1983 and/or this deed and/or any subsitute mortgage.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges over the right title and interest in 1. boeing 727 - 217 aircraft serial no 21056 reg mark g-bkng. 3 pratt & whitney jt 8D-d engines serial nos 688044,688054 and 688065 2. the lease dated 1ST dec. 1983 and any sub lease. 3. bank guarantee. 4. the purchase agreement 5. all moneys in sterling current account no 51511022 at the banks cannon street branch. (Please see doc M23 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bank of America Nt & Sa
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0