AIR 2000 AVIATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AIR 2000 AVIATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01232085 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AIR 2000 AVIATION LIMITED?
- Nichtlinienflugverkehr für Passagiere (51102) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich AIR 2000 AVIATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AIR 2000 AVIATION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OWNERS ABROAD AVIATION LIMITED | 11. Juli 1984 | 11. Juli 1984 |
| OWNERS ABROAD WHOLESALE LIMITED | 03. Nov. 1975 | 03. Nov. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AIR 2000 AVIATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AIR 2000 AVIATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 09. Mai 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 15. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christine Margaret Browne am 16. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joyce Walter am 24. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs. Joyce Walter am 24. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AIR 2000 AVIATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTER, Joyce | Sekretär | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | British | 76169540002 | ||||||
| BROWNE, Christine Margaret | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 79573340002 | |||||
| WALTER, Joyce | Geschäftsführer | Tui Travel House Crawley Business Quarter RH10 9QL Fleming Way, Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 76169540003 | |||||
| BUCKLEY, Peter Eric | Sekretär | Pine Lodge Worthing Road Southwater RH13 9AT Horsham West Sussex | English | 14052080002 | ||||||
| STARLING, Rebecca Jean Godwin | Sekretär | 11 Rossdale Road Putney SW15 1AD London | British | 45381850004 | ||||||
| ADDISON SMITH, Nigel | Geschäftsführer | 49 Fullerton Road Wandsworth SW18 1BU London | British | 46750900002 | ||||||
| ALLARD, Roger Jeffrey | Geschäftsführer | 4a Elystan Street SW3 3NS London | United Kingdom | English | 81122260002 | |||||
| BRYANT, Robert David | Geschäftsführer | Dorill Church Road, Buxted TN22 4LT Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 152320790001 | |||||
| BUNN, James Richard | Geschäftsführer | Great Lime Kiln RH13 9JL Southwater 28 West Sussex United Kingdom | British | 98013270002 | ||||||
| GILL, David Alan | Geschäftsführer | 5 Chanctonbury Drive SL5 9PT Sunningdale Berkshire | England | British | 37437870002 | |||||
| HEALD, Malcolm Barclay | Geschäftsführer | Summerley House Ellwood Road HP9 1EN Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 1605080001 | |||||
| HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | 109591300001 | |||||
| HUMPHRIES, Michael | Geschäftsführer | 3 Paget Close RH13 6HD Horsham West Sussex | England | British | 38432430001 | |||||
| KLEIN, Howard Malcolm | Geschäftsführer | 14 Claybury Hall Repton Park IG8 8RW Woodford Green Essex | British | 105173540001 | ||||||
| MAY, Iain Richard Campbell | Geschäftsführer | Oak Tree House 17 Curlew Close Tytherington SK10 2SX Macclesfield Cheshire | Gbr | British | 32619030002 | |||||
| MOIR, Lance Stuart | Geschäftsführer | 86 Riversdale Road N5 2JZ London | British | 51082180002 | ||||||
| SALMON, Tina | Geschäftsführer | 31 Waverley Avenue Chingford E4 8HS London | British | 28958240001 | ||||||
| SEMPLE, Alan Haig | Geschäftsführer | Foxley House 20 Lynch Hill Park RG28 7NF Whitchurch Hampshire | British | 67061580001 | ||||||
| SINCLAR, Vari | Geschäftsführer | 8 Bethune Close Worth RH10 7WB Crawley West Sussex | British | 38474450001 | ||||||
| SMITH, Kenneth William | Geschäftsführer | 10 Martello Mews BN25 1JT Seaford East Sussex | British | 87819940001 | ||||||
| STEVENS, Robert | Geschäftsführer | 4 Chiltenhurst TN8 5PJ Edenbridge Kent | England | British | 83941990001 | |||||
| STONE, Geofrey George | Geschäftsführer | 7 Harcourt Manor Harcourt Terrace SP2 7SA Salisbury Wiltshire | England | British | 44562670002 |
Hat AIR 2000 AVIATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed relating to netting and payment arrangements | Erstellt am 28. Feb. 1997 Geliefert am 12. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any obligation for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, joint or several and whether incurred as principal or surety, including principal, interest, commission, fees and other lawful charges and expenses for which a participant (as defined) may be or become liable to the chargee (in its capacity as security trustee) and the banks (as defined) | |
Kurze Angaben By clause 3.1 of the deed, the company agreed that each bank may, at any time or times on or after the enforcement date (as defined in the inter-creditor agreement) without notice, set off any or all sums of money now or subsequently standing to the credit of the company (including any unmatured deposit or any deposit in respect of which the appropriate call notice has not been given) against all or such part of such indebtedness as such bank may determine (whether presently payable or not).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over deposit | Erstellt am 30. Okt. 1990 Geliefert am 19. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 30/10/90 and/or this charge | |
Kurze Angaben The aggregate amount at any relevant time standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company opened, or as the code may be, to be opened in the books of mars nominees LTD. (Please see 395 M82 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 12. Apr. 1989 Geliefert am 21. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 12/4/89 and this charge | |
Kurze Angaben All the companys right title and interest in and to all monies which wereat the date of assignment (see 395 & cont sheet m 125C for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 20. Okt. 1988 Geliefert am 09. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a bond facility agreement dated 20 oct 1988 and this charge. | |
Kurze Angaben All the companys rights title and interest in and to all moneys standing to the credit of the blocked deposit accounts in the name of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 28. Sept. 1988 Geliefert am 18. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement of even date and this charge | |
Kurze Angaben The aggregate amount standing to the credit of the blocked deposit account in the name of the company open or to be opened in the books of guinness mahon nominees limited ( see form 395 and continuation sheet relevant to the charge ). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 01. Dez. 1987 Geliefert am 08. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the charge | |
Kurze Angaben Boeing modle 727-217 reg. Mark g - nroa serial no- 21056 engines serial nos 686371, 688042 and 707910. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Feb. 1987 Geliefert am 26. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 1,000,000 and other all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben One boeing 727-217 aircraft with reg. No g-nroa including all spare parts and all spare aircraft engines for the aircraft. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement | Erstellt am 23. Mai 1986 Geliefert am 31. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag An amount standing to the credit of a bank acount which shall not exceed a maximum amount of £300,000 together with the pull amount of any balance of sale proceeds relating to the sale of an aircraft remaining after any mortgages have been discharged in full. | |
Kurze Angaben A bank account and the balance of sale proceeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 23. Mai 1986 Geliefert am 27. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86 | |
Kurze Angaben All the companys present & future lights benefite & interest in the boeing 727 -217 advanced net air craft & manufacturers serial number 21056. and UK registration mark g- nroa, its engines any replacement and equipment from time to time installed thereof the insurances (other than liability mcullances) and earnings of the aircraft. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft mortgage | Erstellt am 23. Mai 1986 Geliefert am 27. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/5/86 | |
Kurze Angaben All the companies rights title and interest to and in any monies payable to the company under an aircraft lease agreement dated 01/12/83. (see doc M27 for full details) and all the companies rights, title and interest to arain any monies whatsoever payable to the company under a guarantee issued on 25/05/86 by lloyds bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. Mai 1986 Geliefert am 27. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 03. Feb. 1986 Geliefert am 06. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27/11/85 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 01. Dez. 1983 Geliefert am 02. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee following the termination in certain circumstances of an aircraft lease agreement dated 1-12-83 | |
Kurze Angaben All the company's rights title and interest to the relevant proportion of the remaining net sales proceeds (all as defined in the said charge and/or aircraft lease agreement). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 01. Dez. 1983 Geliefert am 02. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30TH november 1983 and/or this deed and/or any subsitute mortgage. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over the right title and interest in 1. boeing 727 - 217 aircraft serial no 21056 reg mark g-bkng. 3 pratt & whitney jt 8D-d engines serial nos 688044,688054 and 688065 2. the lease dated 1ST dec. 1983 and any sub lease. 3. bank guarantee. 4. the purchase agreement 5. all moneys in sterling current account no 51511022 at the banks cannon street branch. (Please see doc M23 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0