CAPE OVERSEAS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CAPE OVERSEAS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01233631 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAPE OVERSEAS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Rotherham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CAPE INDUSTRIES OVERSEAS LIMITED | 14. Nov. 1975 | 14. Nov. 1975 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2021
| 2 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2020 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2019 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Padraig Somers als Direktor am 28. Juni 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Cape Admin 1 Limited als Geschäftsführer am 28. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Cape Admin 1 Limited am 04. Feb. 2019 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Drayton Hall Church Road West Drayton Middlesex England UB7 7PS zum Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe Goldthorpe Rotherham S63 0JF am 30. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2018 bis 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Cape Admin 1 Limited als Direktor am 25. Mai 2018 | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Hooper als Geschäftsführer am 25. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Anthony Meade Walsh am 08. Feb. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Anthony Meade Walsh als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victoria Anne George als Geschäftsführer am 15. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMERS, Padraig | Geschäftsführer | Island Ganniv Greenville Listowel 3 Co. Kerry Ireland | Ireland | Irish | 259818620001 | |||||||||
| WALSH, John Anthony Meade | Geschäftsführer | Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Building 2, Fields End Business Park Rotherham England | United Kingdom | British | 238138720001 | |||||||||
| ALLAN, Richard Friend | Sekretär | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | 181730640001 | |||||||||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Sekretär | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | British | 82905830002 | ||||||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Sekretär | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675310001 | |||||||||||
| JUDD, Christopher Francis | Sekretär | Millenia Tower One Temasek Avenue Singapore #09-03 039192 Singapore | 169531010001 | |||||||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Sekretär | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||||||
| RHODES, Jeremy | Sekretär | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||||||
| SMITH, Stephen Harry | Sekretär | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||||||
| TURNER, Lucy Finch | Sekretär | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||||||
| AINLEY, Paul Raymond | Geschäftsführer | Manasseh Darrington Road WF8 3RY Pontefract West Yorkshire | British | 36049300001 | ||||||||||
| ALLAN, Richard Friend | Geschäftsführer | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 183409640001 | |||||||||
| AMEY, Rachel Nancye | Geschäftsführer | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 133976650005 | |||||||||
| BINGHAM, Richard Keith | Geschäftsführer | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | 131046090001 | ||||||||||
| CARTWRIGHT, Paul Ian | Geschäftsführer | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | 40873830002 | ||||||||||
| CRAIGIE, Claire Louise | Geschäftsführer | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | England | British | 82905830002 | |||||||||
| DOWLING, Christopher Bruce | Geschäftsführer | 20 Bramcote Road Putney SW15 6UG London | Australian | 28868820002 | ||||||||||
| FAREBROTHER, Michael John | Geschäftsführer | The Old Cottage Pednor HP5 2SX Chesham Buckinghamshire | British | 15332520001 | ||||||||||
| GARTSIDE, Jeremy Peter | Geschäftsführer | The Grange Kelshall SG8 9SE Royston Hertfordshire | British | 28782670001 | ||||||||||
| GEORGE, Victoria Anne | Geschäftsführer | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||||||
| GIBSON, Andrew Christopher | Geschäftsführer | Lingerfield Barn Market Flat Lane Scotton HG5 9JA Knaresborough North Yorkshire | British | 101703790001 | ||||||||||
| GILLESPIE, Andrew James | Geschäftsführer | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 89560440001 | |||||||||
| GRATTON, Gordon Cameron Paul | Geschäftsführer | 1 Beckside Gardens LS16 5QZ Leeds West Yorkshire | England | British | 121813940001 | |||||||||
| HOOPER, Mark | Geschäftsführer | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | British | 183414240001 | |||||||||
| JACKSON, Francis Keith John | Geschäftsführer | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | 15469790001 | |||||||||
| PITT-PAYNE, Michael George | Geschäftsführer | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 829660002 | |||||||||
| REYNOLDS, Michael Thomas | Geschäftsführer | 185 Adel Lane LS16 8BY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 4978610002 | |||||||||
| SKIPP, Richard John | Geschäftsführer | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | England | British | 164010970001 | |||||||||
| SMITH, Stephen Harry | Geschäftsführer | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | 64449570001 | ||||||||||
| WHITWORTH, Benjamin Warwick | Geschäftsführer | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | 99402260002 | |||||||||
| WIDDOWSON, Ian Richard | Geschäftsführer | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 16941000001 | ||||||||||
| CAPE ADMIN 1 LIMITED | Geschäftsführer | Fields End Business Park Davey Road S63 0JF Goldthorpe Building 2 Rotherham United Kingdom |
| 194285370001 | ||||||||||
| CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAPE OVERSEAS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Industrial Services Group Limited | 06. Apr. 2016 | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CAPE OVERSEAS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 03. Sept. 2007 Geliefert am 13. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 26. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 01. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 20. Juli 2001 Geliefert am 26. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined) | |
Kurze Angaben Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0