COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01239073 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Breakspear Park Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Cessation of James Douglas Mcfarlane as a person with significant control on 14. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 11th Floor Two Snow Hill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6WR verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Notification of Redsky It (Crick) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Notification of James Douglas Mcfarlane as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 03. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012390730009, erstellt am 22. Nov. 2017 | 83 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Richard Henwood als Sekretär am 25. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFARLANE, James Douglas | Geschäftsführer | 730 Eyremount Drive West Vancouver Bc V76 2a4 Canada | Canada | Canadian | 118810110004 | |||||
| COSTER, Malcolm David | Sekretär | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Sekretär | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| HENWOOD, Julian Richard | Sekretär | 8 Brickyard Close CV7 7EN Balsall Common Warwickshire | British | 65188860002 | ||||||
| TAYLOR, David | Sekretär | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| BELLAMY, Paul Anthony | Geschäftsführer | 9 Sadbury Close Worle BS22 0QP Weston Super Mare Avon | British | 34463620001 | ||||||
| BRADLEY, Michael John | Geschäftsführer | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Geschäftsführer | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||
| EVANS, Robert Owen | Geschäftsführer | Hollybank 32 Birches Lane CV8 2AD Kenilworth Warwickshire | British | 57011000001 | ||||||
| FLYNN, Thomas Desmond | Geschäftsführer | Larch Cottage 39 Bagley Wood Road Kennington OX1 5LY Oxford Oxfordshire | British | 16993890001 | ||||||
| FOSTER, Michael | Geschäftsführer | The Ash Grove 91 Bretby Lane DE15 0QP Burton On Trent Staffordshire | British | 34463630001 | ||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| JONES, Nicholas David Brandon | Geschäftsführer | 16 Dallington Park Road NN5 7AA Northampton Northamptonshire | British | 16993910001 | ||||||
| LOMAX, John Kevin | Geschäftsführer | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||
| MATTHEW, Gordon John | Geschäftsführer | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||
| SINFIELD, Christopher | Geschäftsführer | Stonelea Cottage 24 Whiston Road Cogenhoe NN7 1NL Northampton Northamptonshire | British | 37887830001 | ||||||
| SMITH, Gordon Saville | Geschäftsführer | 32 St Peters Avenue NN16 0HA Kettering Northamptonshire | British | 2436530001 | ||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | 25 Jordan Road B75 5AB Sutton Coldfield West Midlands | British | 1442450001 | ||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| TEBBUTT, Arthur Mark | Geschäftsführer | 26 Grange Road Geddington NN14 1AL Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | 2436540001 | |||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Geschäftsführer | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr James Douglas Mcfarlane | 06. Apr. 2016 | Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Breakspear Park Hertfordshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: Canadian Staatsangehörigkeit: Canada | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Redsky It (Crick) Limited | 06. Apr. 2016 | Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempstead Breakspear Park Hertfordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 07. Nov. 2016 | 03. Apr. 2018 | Das Unternehmen hat eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, jedoch wurden nicht alle erforderlichen Angaben zu dieser Person bestätigt. |
Hat COULSON HERON ASSOCIATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 22. Nov. 2017 Geliefert am 29. Nov. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Jan. 2015 Geliefert am 03. Feb. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Coulson heron associates limited charges by way of fixed charge any right, title or interest which it has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture).. Coulson heron associates limited charges by way of legal mortgage the land at redsky house, eldon way, crick industrial estate, crick NN6 7SL with title number NN295077.. Coulson heron associates limited charges by way of first fixed charge all trade mark property, copyrights and related rights (as defined in the debenture), including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Jan. 2014 Geliefert am 07. Feb. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Fixed charge over any right/ title/ interest which the company has or acquires over any other land.. Fixed charge over trade marks, any good will relating to a trade mark, any other right arising from, relating to, or associated with any trade mark or its use in a chargor’s business, copyrights and all other intellectual property rights (including all fees, royalties, and other rights). This applies to any intellectual property owned presently by the chargor or at any time between the date of the debenture (31 january 2014) and the date on which the security trustee is satisfied (acting reasonably) that all of the liabilities of the loan parties under each finance document are irrevocably discharged in full and no finance party has any commitment or liability, whether present or future, actual or contingent, in relation to the facility made available under the finance documents. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The collateral being all right in the accounts books chattel paper deposit accounts equipment and fixtures general intangibles inventory investment related property negotiable collateral supporting obligations, commercial tort claims, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| General security agreement | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The collateral being all right in the undertaking and personal property which includes accounts chattel paper documents of title equipment goods instruments inventory investment property and money, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Copyright security agreement | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the copyrights and copyright intellectual property licences all renewals or extensions of the foregoing and all products and proceeds of the foregoing see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trademark security agreement | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its trademarks and trademark intellectual property licences all goodwill of the business and all products and proceeds of the foregoing see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juni 1985 Geliefert am 24. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold proeprty known as eldon way crick northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0