BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01240464 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Parkview 1220 Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GREENHOW & WELCH LIMITED | 04. Dez. 1989 | 04. Dez. 1989 |
| GREENHOW HOLDINGS LIMITED | 01. Dez. 1986 | 01. Dez. 1986 |
| GREENHOW & WRIGHT LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Graham Middlemiss am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Graham Middlemiss als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tom Brophy als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Drew als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Tom Brophy als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 30 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Webster als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Andrew Ross Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLEMISS, Graham | Sekretär | Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading Parkview 1220 United Kingdom | 174236480001 | |||||||
| SMITH, Robert Andrew Ross | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading Parkview 1220 United Kingdom | United Kingdom | British | 150753930001 | |||||
| WOLSELEY DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Parkview 1220 Arlington Business Park, Theale RG7 4GA Reading | 122185200001 | |||||||
| BROPHY, Tom | Sekretär | Parkview 1220 Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading | 162215330001 | |||||||
| DREW, Alison | Sekretär | Parkview 1220 Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading | British | 86845230002 | ||||||
| FITCHETT, Angela | Sekretär | 27 Wickery Dene Wootton NN4 6BE Northampton | British | 25979740002 | ||||||
| PARKER, Edward Geoffrey | Sekretär | The Homestead 133 Malvern Road WR2 4LN Worcester | British | 37378570013 | ||||||
| PRIEST, Mark Richard | Sekretär | 2 West Hill Avenue LS7 3QH Leeds West Yorkshire | British | 60944350002 | ||||||
| WEATHERHEAD, Tina Michelle | Sekretär | Glencoe Hollins Lane, Hampsthwaite HG3 2HL Harrogate North Yorkshire | British | 75258960001 | ||||||
| WHITE, Mark Jonathan | Sekretär | 38 Grange Close Church Road Nascot Wood WD17 4HQ Watford Hertfordshire | British | 82978250001 | ||||||
| BARDEN, Adrian | Geschäftsführer | 1 Croxton Gardens PE28 0SE Catworth Cambridgeshire | British | 66429950001 | ||||||
| BRADLEY, David | Geschäftsführer | Hambleton Grange Burton Leonard HG3 3RX Harrogate North Yorkshire | British | 65302630001 | ||||||
| BRANSON, David Anthony | Geschäftsführer | 32 Chestnut Drive Shenstone WS14 0JH Lichfield Staffordshire | British | 272310001 | ||||||
| GREENHOW, Frederick | Geschäftsführer | Tithe Barn South Street Isham NN14 1HP Kettering Northamptonshire | British | 6180130001 | ||||||
| HEMMINGTON, Neil John | Geschäftsführer | 41 Stourhead Drive East Hunsbury NN4 0UH Northampton | British | 25979750001 | ||||||
| PARKER, Edward Geoffrey | Geschäftsführer | The Homestead 133 Malvern Road WR2 4LN Worcester | British | 37378570013 | ||||||
| WEBSTER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Parkview 1220 Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading | United Kingdom | British | 40201730005 | |||||
| WELCH, Ian | Geschäftsführer | 20 Rowlandson Close Weston Favell NN3 3PB Northampton Northamptonshire | British | 6246010001 | ||||||
| WHITE, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Hawthorn House 2 Wards Drive, Sarratt WD3 6AE Rickmansworth Herts | England | British | 82978250002 |
Hat BRACKMILLS BUILDING SUPPLIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Jan. 1988 Geliefert am 20. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Site at brackmills northampton and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Aug. 1985 Geliefert am 29. Aug. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as land in cambridge road, st. Neats in the county of cambridge and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Jan. 1985 Geliefert am 15. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Specific equitable charge over all estates or interest in any l/h & f/h property. Specific charge over all stocks, shares, and/or other securities, all book & other debts & the proceeds of sale the goodwill & benefit of any licenes. Floating securty over its undertaking & all its property assets & rights present or future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Jan. 1985 Geliefert am 15. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildigs on the west side of window road bedford. T/n bd 22471. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Okt. 1980 Geliefert am 07. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property known as station yard adjacent to station road kettering northamptonshire a fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. (See doc M24 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Okt. 1980 Geliefert am 07. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property known as station yard adjacent to station road kettering northamptonshire together with all easements rights and privileges appartment or belonging thereto.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0