SANTA BARBARA HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SANTA BARBARA HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01243282 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 55 Baker Street London W1U 7EU verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Elizabeth Fabni am 04. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Marriott Harrison Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH United Kingdom zum 55 Baker Street London W1U 7EU geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2015 bis 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 189-190 Queen's Gate London SW7 5EX zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 19. Aug. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mh Secretaries Limited als Sekretär am 07. Juli 2014 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Con Christopher Ring als Geschäftsführer am 07. Juli 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Murphy als Geschäftsführer am 07. Juli 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Giovanni Battista Decandia als Direktor am 07. Juli 2014 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Elizabeth Fabni als Direktor am 07. Juli 2014 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Peter Murphy als Direktor am 25. Jan. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Thomas Bracken als Geschäftsführer am 25. Jan. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SANTA BARBARA HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECANDIA, Giovanni Battista | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | Italy | Italian | 189696300001 | |||||||||
| FABRI, Elisabetta | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | Italy | Italian | 187748230001 | |||||||||
| MCKAY, Peter Beverley | Sekretär | 15 Mayford Road SW12 8RZ London | English | 5263580002 | ||||||||||
| QUIGLEY, Con | Sekretär | Horwath House The Red Church Henry Street Horwath Bastow Charleton Limerick Ireland | British | 148178500001 | ||||||||||
| MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London Staple Court United Kingdom |
| 39754020001 | ||||||||||
| MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Staples Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 39754020001 | |||||||||||
| BLAIN, Douglas Ellis | Geschäftsführer | 23 Brompton Square SW3 2AD London | United Kingdom | British | 29943890001 | |||||||||
| BRACKEN, Edward Thomas | Geschäftsführer | 40 Herons Place Old Isleworth TW7 7BE London | United Kingdom | Irish | 121058070001 | |||||||||
| DALE-THOMAS, Brian Dale | Geschäftsführer | 39 Poultons Square SW3 London | British | 32158880003 | ||||||||||
| DALE-THOMAS, Norfudd Aminge | Geschäftsführer | 39 Poultons Square SW3 London | British | 32158890002 | ||||||||||
| HULTON, Cosmo | Geschäftsführer | Hill House 3 Upland Road St. Peter Port GY1 1UJ Guernsey Channel Islands | Guernsey | English | 7215070003 | |||||||||
| MCKAY, Peter Beverley | Geschäftsführer | 15 Mayford Road SW12 8RZ London | United Kingdom | English | 5263580002 | |||||||||
| MURPHY, Peter | Geschäftsführer | 189-190 Queen's Gate London SW7 5EX | Ireland | Irish | 114920360002 | |||||||||
| RING, Con Christopher | Geschäftsführer | Halford Road TW10 6AP Richmond 6 Surrey | United Kingdom | Irish | 115593320001 |
Hat SANTA BARBARA HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2006 Geliefert am 09. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 20. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as 189-190 queensgate london SW7 5EX. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 27. Mai 1994 Geliefert am 06. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over its goodwill and the benefit of any licences all patents patent applications inventions trade-marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1990 Geliefert am 28. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the gove hotel 189/190 queens gate london SW7 title no ln 131122. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1980 Geliefert am 01. Apr. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as the gore hotel 189/190 queens gate S.w 7 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery title no. Ln 131122. all other f/h & l/h property of the company now vested in it together with. Buildings fixtures fixed plant and machinery. Fixed charge all future f/h & l/h property of the company together with all buildings fixtures & fixed plant and machinery and all the goodwill & uncalled capital of the company. Fixed charge on book & other debts of the company floating charge over all other the undertaking and assets of the company whatsoever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0