SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01243319 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALAN FARROW GROUP LIMITED | 23. Juli 1987 | 23. Juli 1987 |
| ALAN FARROW (PAPER SALES) LIMITED | 06. Feb. 1976 | 06. Feb. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Juli 2022 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kathryn Anne Davenport als Sekretär am 04. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Old Mills Drighlington Bradford West Yorkshire BD11 1BY zum C/O Mha Macintyre Hudson 6th Floor 2 London Wall Place London EC2Y 5AU am 03. Aug. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anna Carina Heilborn als Geschäftsführer am 15. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Olof Hager als Direktor am 15. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lars John Rutegard als Geschäftsführer am 22. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Anna Carina Heilborn als Direktor am 22. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin | Geschäftsführer | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | Sweden | Swedish | 200856740001 | |||||
| HAGER, John Olof | Geschäftsführer | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | Sweden | Swedish | 224855100001 | |||||
| DAVENPORT, Kathryn Anne | Sekretär | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | 154635000001 | |||||||
| FEARNS, David | Sekretär | 10 Prince Wood Lane HD2 2DG Huddersfield West Yorkshire | British | 50694840002 | ||||||
| LEVIS, Sue Jane Holden | Sekretär | 23 Legh Road Prestbury SK10 4HX Macclesfield Cheshire | British | 54558780002 | ||||||
| THORNTON, Richard James | Sekretär | The Old Farm Nant Alyn Road Rhydymwyn CH7 5HQ Mold Flintshire | British | 57845280001 | ||||||
| WEATHERSTONE, Andrew Paul | Sekretär | 6 Spring Farm Applehaigh Lane Notton WF4 2PT Wakefield West Yorkshire | British | 86724380003 | ||||||
| FARROW, Alan Charles | Geschäftsführer | White Gables 10 Howard Drive Hale WA15 0LT Altrincham Cheshire | British | 24228450001 | ||||||
| FEARNS, David | Geschäftsführer | 10 Prince Wood Lane HD2 2DG Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 50694840002 | |||||
| FERGUSON, Michael Alexander | Geschäftsführer | Emmanuel House Brettargh Drive LA1 5BN Lancaster Lancashire | United Kingdom | British | 66192260001 | |||||
| GIDDENS, Keith | Geschäftsführer | Dunkirk Lane PR26 7SP Leyland 204 Lancashire | British | 129004170001 | ||||||
| GREEN, Joan | Geschäftsführer | The Grannary Reed Hall Court Hammond Drive PR2 2GB Read Lancashire | British | 54389240001 | ||||||
| GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin | Geschäftsführer | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | 76805000001 | |||||
| HALSTEAD, Roger | Geschäftsführer | Myerscough Road Mellor Brook BB2 7LB Blackburn 1 Hawthorn Cottage Lancashire | British | 129004340001 | ||||||
| HEILBORN, Anna Carina | Geschäftsführer | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | 200857260001 | |||||
| KNIGHTON, Ian | Geschäftsführer | The Granary Read Hall Court Hammond Drive Read BB12 7RU Burnley Lancashire | British | 24228460005 | ||||||
| LECKIE, Brian | Geschäftsführer | Cherrytree Farm Briestfield Road, Briestfield WF12 0NR Dewsbury West Yorkshire | United Kingdom | British | 47711920002 | |||||
| PICKERING, Alan | Geschäftsführer | Fox Clough Barn Birchenlee Lane BB8 8HL Colne Lancashire | British | 46502390001 | ||||||
| RUTEGARD, Lars John | Geschäftsführer | Drighlington BD11 1BY Bradford Old Mills West Yorkshire | Sweden | Swedish | 180685960001 | |||||
| SCAIFE, Terence, Dr | Geschäftsführer | Fintry Fairmoor NE61 3JL Morpeth Northumberland | British | 61529090001 | ||||||
| SHAW, Clive Michael | Geschäftsführer | Grey Cedars Cartworth Road Holmfirth HD7 1RQ Huddersfield West Yorkshire | British | 9522360001 | ||||||
| TURNER, Deborah | Geschäftsführer | Wisteria Drive Lower Darwen BB3 0QY Darwen 31 Lancashire | British | 129004000001 | ||||||
| WEATHERSTONE, Andrew Paul | Geschäftsführer | 6 Spring Farm Applehaigh Lane Notton WF4 2PT Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 86724380003 | |||||
| WILLIAMS, Andrew John | Geschäftsführer | 25 Palesides Avenue Ossett WF5 9NL Wakefield West Yorkshire | England | British | 124172140001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Peter Gyllenhammar | 06. Apr. 2016 | 6th Floor 2 London Wall Place EC2Y 5AU London C/O Mha Macintyre Hudson England | Nein |
Nationalität: Swedish Staatsangehörigkeit: Sweden | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2010 Geliefert am 02. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over shares | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 10. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the charged securities referred to in the schedule to the share charge namely 800 ordinary shares of £1 each held by the company in the share capital together with all related rights. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 2007 Geliefert am 06. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 23. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The stocks, shares, bonds, debentures or other securities deposited with or transferred to the chargee or trustees for or nominees of the chargee being 1,999 £1 ordinary shares of blackburn gravure limited, 401,999 £1 ordinary shares of darwen coatings and adhesices limited, 2,000 £1 ordinary shares of speciality coatings (darwen) limited.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Nov. 2000 Geliefert am 20. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever except any moneys or liabilities due or to become due by such company as guarantor for the chargor. | |
Kurze Angaben F/H property at moorside and south end mills dewhurst street darwen t/nos LA590425 LA519762 and LA553274. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 06. Aug. 1996 Geliefert am 14. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Feb. 1988 Geliefert am 16. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whitemill and adjoining land and buildings off denhurst street darwen lincolnshire t/no la 519762 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 11. Apr. 1986 Geliefert am 17. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SPECIALITY COATINGS GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0